RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED

RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03200097
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wey Court West
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOUTHERN LAND DEVELOPMENTS LIMITED17 mai 199617 mai 1996

    Quels sont les derniers comptes de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 déc. 2017

    1 pagesAA01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2016

    État du capital au 15 juin 2016

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2015

    État du capital au 12 juin 2015

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Anthony Watkins en tant que secrétaire le 15 juil. 2014

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Paul Anthony Watkins en tant que directeur le 15 juil. 2014

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Towngate House 2-8 Parkstone Road Poole Dorset BH15 2PW à Wey Court West Union Road Farnham Surrey GU9 7PT le 30 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2014

    État du capital au 23 juin 2014

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 17 mai 2012

    16 pagesRP04

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    3 pagesSH10

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    État du capital après une attribution d'actions au 20 juin 2012

    • Capital: GBP 6
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Robert Mark
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    Administrateur
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    EnglandBritish46522020003
    TAYLOR, Helen
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    Secrétaire
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    British89688100002
    WATKINS, Paul Anthony
    Glenair Road
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    Secrétaire
    Glenair Road
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    British36877870003
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BELL, Matthew Robin
    Flat 5 Thistle Court
    28 Warwick Road, Boscombe
    BH7 6LB Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    Flat 5 Thistle Court
    28 Warwick Road, Boscombe
    BH7 6LB Bournemouth
    Dorset
    British99628170002
    HILL, Richard James Barclay
    8 Orchardleigh Park
    21 Dean Park Road
    BH1 1HX Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    8 Orchardleigh Park
    21 Dean Park Road
    BH1 1HX Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish41718540001
    KEEYS, William Albert
    14 Woodlake Close
    BH17 9FE Poole
    Dorset
    Administrateur
    14 Woodlake Close
    BH17 9FE Poole
    Dorset
    EnglandBritish99628190001
    WATKINS, Paul Anthony
    Glenair Avenue
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    Administrateur
    Glenair Avenue
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    British36877870004
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Wey Court West
    Surrey
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Wey Court West
    Surrey
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleThe Companies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03404258
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 2004
    Livré le 13 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land at manor farm site, dorchester road, frampton dorset by way of first fixed charge all the machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishings equipment tools and other chattels, the rental income, by way of floating charge all the undertaking and all property.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 13 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 sept. 2003
    Livré le 20 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 2003
    Livré le 21 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a tor sands hotel 8 sands road paignton title absolute t/n DN83974 together with all buildings fixtures and erections thereon; fixed charge all monies received under any policy of insurance,the goodwill of any business and any share held in any management company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 21 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 juin 2002
    Livré le 09 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 09 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 2002
    Livré le 09 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal charge the property k/a southlands, northfield road, minehead, t/n ST149054, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 09 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 2002
    Livré le 09 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal charge the property k/a rectory house hotel and adjoining land, northfield road, minehead, somerset, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 09 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 28 août 2001
    Livré le 04 sept. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Coram court and land on the west side of coram court sidmouth road lyme regis t/no;-DT276150 DT274706 all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings and equipment all goodwill rental income present and future and floating charge over undertaking and all property and assets not charged by way of fixed charge above.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 04 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Second legal charge
    Créé le 28 août 2001
    Livré le 01 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £225,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Coram court sidmouth road lyme regis dorset t/nos: DT276150 and DT274706 subject to a first charge dated 28TH august 2001 in favour of close brothers limited.
    Personnes ayant droit
    • John William Stenson and Judith Elizabeth Stenson
    Transactions
    • 01 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 2001
    Livré le 17 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Coram court sidmouth road lyme regis dorset.
    Personnes ayant droit
    • J and J Stenson Limited
    Transactions
    • 17 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 22 mai 1998
    Livré le 23 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plots A1-A4 phase 1 section a pandbury bridport road dorchester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 25 avr. 1997
    Livré le 30 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All of the company's benefit, right, title and interest under arising out of or vested in the company pursuant to the development agreement of even date. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 12 nov. 1996
    Livré le 14 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0