RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03200097 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Wey Court West Union Road GU9 7PT Farnham Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 déc. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Anthony Watkins en tant que secrétaire le 15 juil. 2014 | 2 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Anthony Watkins en tant que directeur le 15 juil. 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Towngate House 2-8 Parkstone Road Poole Dorset BH15 2PW à Wey Court West Union Road Farnham Surrey GU9 7PT le 30 juil. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 17 mai 2012 | 16 pages | RP04 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Détails de la variation des droits attachés aux actions | 3 pages | SH10 | ||||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 20 juin 2012
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 6 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Robert Mark | Administrateur | 5 The Green Bloxworth BH20 0AA Wareham Dorset | England | British | 46522020003 | |||||
| TAYLOR, Helen | Secrétaire | 5 The Green Bloxworth BH20 0AA Wareham Dorset | British | 89688100002 | ||||||
| WATKINS, Paul Anthony | Secrétaire | Glenair Road Parkstone BH148AD Poole 4 Dorset United Kingdom | British | 36877870003 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| BELL, Matthew Robin | Administrateur | Flat 5 Thistle Court 28 Warwick Road, Boscombe BH7 6LB Bournemouth Dorset | British | 99628170002 | ||||||
| HILL, Richard James Barclay | Administrateur | 8 Orchardleigh Park 21 Dean Park Road BH1 1HX Bournemouth Dorset | England | British | 41718540001 | |||||
| KEEYS, William Albert | Administrateur | 14 Woodlake Close BH17 9FE Poole Dorset | England | British | 99628190001 | |||||
| WATKINS, Paul Anthony | Administrateur | Glenair Avenue Parkstone BH148AD Poole 4 Dorset United Kingdom | British | 36877870004 | ||||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Renaissance Group Of Companies Limited | 06 avr. 2016 | Union Road GU9 7PT Farnham Wey Court West Surrey United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 28 oct. 2004 Livré le 13 nov. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Property k/a land at manor farm site, dorchester road, frampton dorset by way of first fixed charge all the machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishings equipment tools and other chattels, the rental income, by way of floating charge all the undertaking and all property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 sept. 2003 Livré le 20 sept. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 19 févr. 2003 Livré le 21 févr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The property k/a tor sands hotel 8 sands road paignton title absolute t/n DN83974 together with all buildings fixtures and erections thereon; fixed charge all monies received under any policy of insurance,the goodwill of any business and any share held in any management company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 juin 2002 Livré le 09 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 juin 2002 Livré le 09 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal charge the property k/a southlands, northfield road, minehead, t/n ST149054, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 juin 2002 Livré le 09 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal charge the property k/a rectory house hotel and adjoining land, northfield road, minehead, somerset, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 28 août 2001 Livré le 04 sept. 2001 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Coram court and land on the west side of coram court sidmouth road lyme regis t/no;-DT276150 DT274706 all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings and equipment all goodwill rental income present and future and floating charge over undertaking and all property and assets not charged by way of fixed charge above. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Second legal charge | Créé le 28 août 2001 Livré le 01 sept. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti £225,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Coram court sidmouth road lyme regis dorset t/nos: DT276150 and DT274706 subject to a first charge dated 28TH august 2001 in favour of close brothers limited. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 09 févr. 2001 Livré le 17 févr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Coram court sidmouth road lyme regis dorset. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage deed | Créé le 22 mai 1998 Livré le 23 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Plots A1-A4 phase 1 section a pandbury bridport road dorchester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 25 avr. 1997 Livré le 30 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All of the company's benefit, right, title and interest under arising out of or vested in the company pursuant to the development agreement of even date. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture deed | Créé le 12 nov. 1996 Livré le 14 nov. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0