FRASERS FB (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFRASERS FB (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03202502
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    95 Cromwell Road
    SW7 4DL London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FRASERS FB (UK) PLC21 déc. 201021 déc. 2010
    FAIRBRIAR PLC02 août 199602 août 1996
    FAIRBRIAR GROUP PLC22 mai 199622 mai 1996

    Quels sont les derniers comptes de FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Nomination de Mr Martin James Ratchford en tant qu'administrateur le 03 mars 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2023

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2022

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2021

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2020

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Seng Khoon Ng en tant que secrétaire le 12 déc. 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Seng Khoon Ng en tant que directeur le 12 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Khong Shoong Chia en tant que directeur le 16 mai 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Ilaria Jane Del Beato en tant qu'administrateur le 27 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon John Patrick Lear en tant que directeur le 27 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 81 Cromwell Road London SW7 5BW à 95 Cromwell Road London SW7 4DL le 01 mai 2018

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2017

    14 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    Cromwell Road
    SW7 4DL London
    95
    England
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 4DL London
    95
    England
    United KingdomBritishChief Executive93124450002
    RATCHFORD, Martin James
    Cromwell Road
    SW7 4DL London
    95
    England
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 4DL London
    95
    England
    EnglandBritishDirector255563630001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Secrétaire
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    British90211410001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director38011750001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7307485
    160736190001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritishAccountant812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritishAccountant812680001
    BOURNE, Robert Anthony
    100 Cheyne Walk
    SW10 0DQ London
    Administrateur
    100 Cheyne Walk
    SW10 0DQ London
    BritishCompany Director70526160001
    CHIA, Khong Shoong
    Alexander Road
    #21-00 Alexandra Point
    Singapore
    438
    119958
    Singapore
    Administrateur
    Alexander Road
    #21-00 Alexandra Point
    Singapore
    438
    119958
    Singapore
    SingaporeSingaporeanChief Financial Officer141112510002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    HAN, Cheng Fong
    3 Toronto Road
    FOREIGN Singapore
    574430
    Administrateur
    3 Toronto Road
    FOREIGN Singapore
    574430
    SingaporeanManaging Director79872410001
    HANKINSON, Derek William
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director822380001
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritishManaging Director107485520001
    LIM, Ee Seng
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    Administrateur
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    SingaporeanSingaporeanDirector123920850001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishSurveyor109250000001
    NG, Seng Khoon
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    EnglandBritishFinancial Director90211410001
    PAIRMAN, Lynda Annette
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    Administrateur
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    BritishSolicitor Company Director132910006
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporeanDirector123800250001
    RICHARDSON, Paul
    2 Harvest Close
    Strensall
    YO32 5SA York
    Appletree House
    North Yorkshire
    Administrateur
    2 Harvest Close
    Strensall
    YO32 5SA York
    Appletree House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller133683730001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Administrateur
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director76943220003
    WALKER, Bruce Layland
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    Administrateur
    59 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    United KingdomBritishDirector82714410001
    WOOD-PENN, Richard Cecil
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishQuantity Surveyor99981260001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director38011750001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FRASERS FB (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    England
    06 avr. 2016
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUk Company Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05402640
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    FRASERS FB (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2010
    Livré le 31 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company each obligor investor or the investors' guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 31 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Corporate trustee mortgage
    Créé le 17 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land k/a 1-27 bolton studios t/no. BGL5153 all fixtures, fittings, plant machinery, manuals and other chattels in respect of the property and all guarantees and warranties in respect of any of them; see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC ("Security Agent")
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of shares
    Créé le 17 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the investments being all the issued share capital of frasers general partner LTD. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of amendment relating to a shares mortgage dated 7 august 2001
    Créé le 10 sept. 2003
    Livré le 19 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from wandsworth riverside quarter limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares mortgage the 26,316 ordinary shares of 1P each in the borrower held by the company and all rights, moneys and property whatsoever;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Shares mortgage
    Créé le 29 mai 2003
    Livré le 17 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed mortgage, the original securities, the additional securities and all related rights in respect of the original securities and additional securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Shares mortgage
    Créé le 07 août 2001
    Livré le 10 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower (as defined) to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    1. the original securities. 2. such other securities as may be issued from time to time by or in respect of the borrower and in which it has an interest (whether legal or equitable) and which shall be specified in an additional schedule which shall be signed by it and the mortgagee for the purposes of identification and shall be annexed to the shares mortgage. 3. all rights, moneys (including, without limitation, dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from, accrue on or be offered in respect of the original securities. (All terms as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 2001
    Livré le 12 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    67 charlesworth house and garage 48, 77 charlesworth house and garage 51, 85 charlesworth house and garage 53 and 87 charlesworth house and garage 68 all at 46-52 stanhope gardens kensington and chelsea t/nos: BGL27244 BGL27220 BGL27222 and BGL27224 .. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2000
    Livré le 13 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h properties being 67 charlesworth house and garage 48, 77 charlesworth house and garage 51, 85 charlesworth house and garage 53 and 87 charleswoth house and garage 68 all at 46-52 stanhope gardens kensington and chelsea t/n's BGL27244, BGL27220, BGL27222 and BGL27224 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 août 1996
    Livré le 07 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0