SURREY COMMUNITY ACTION
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SURREY COMMUNITY ACTION |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 03203003 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SURREY COMMUNITY ACTION ?
| Adresse du siège social | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SURREY COMMUNITY ACTION ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SURREY COMMUNITY ACTION ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 11 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SURREY COMMUNITY ACTION ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Peter John Downey en tant qu'administrateur le 26 nov. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 26 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Keith Robert Mcpherson en tant que directeur le 28 mai 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alison Jane Keeley en tant que directeur le 26 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 26 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 26 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Ms Alison Keeley en tant qu'administrateur le 26 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Elliot Ben Kortenray en tant que directeur le 26 avr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Janice Hutchins en tant que directeur le 26 avr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 25 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Jan Rogers en tant qu'administrateur le 21 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jo Josh en tant que directeur le 30 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr John Skivington en tant qu'administrateur le 01 févr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Simon Charles Matthews en tant que directeur le 26 janv. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kathleen Martha Mcdougall en tant que directeur le 26 janv. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 27 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Anthony Ryder en tant que directeur le 13 mai 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Kathleen Martha Mcdougall en tant qu'administrateur le 08 avr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 31 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Janice Hutchins en tant qu'administrateur le 13 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de SURREY COMMUNITY ACTION ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHACKLETON, George | Secrétaire | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | 255237220001 | |||||||
| CANNON, Michael Charles | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 52687930002 | |||||
| DOWNEY, Peter John | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 343519120001 | |||||
| ROGERS, Jan | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 294990980001 | |||||
| SKIVINGTON, John | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 292342450001 | |||||
| STANTON, Christopher Richard | Administrateur | Grange Road GU2 9QX Guildford 209 England | United Kingdom | British | 160370680001 | |||||
| TAYLOR, Roger Sewell | Administrateur | Larchwood The Street Wonersh GU5 0PG Guildford Surrey | England | British | 77531140001 | |||||
| FOYSTER, Amanda Catherine | Secrétaire | 70 Farncombe Street Farncombe GU7 3LN Godalming Surrey | British | 38773550001 | ||||||
| GRANT, Julia Catherine | Secrétaire | Elmtrees Oakcroft Road KT14 6JH West Byfleet Surrey | British | 60020110001 | ||||||
| PRESCOTT-MARTIN, James | Secrétaire | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | 165734710001 | |||||||
| ROBERTS JONES, Jean Elna | Secrétaire | 18 Porteous Crescent Chandlers Ford SO53 2DH Eastleigh Hampshire | British | 45256350001 | ||||||
| AKHTAR, Kauser Parveen | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 172934820001 | |||||
| ALLENBY, Anthony Mansfield | Administrateur | 21 Bramley Grange GU5 0ES Bramley Surrey | British | 40782250002 | ||||||
| BEAZLEY, David John | Administrateur | 9 Mount Close Hook Heath GU21 0PZ Woking Surrey England | British | 47781180001 | ||||||
| CHANEY, John Christopher | Administrateur | Roselawn 8 Delta Road Chobham GU24 8PY Woking Surrey | England | British | 107973340001 | |||||
| CLACK, Helyn Yarwood | Administrateur | Beenleigh Russ Hill Charlwood RH6 0EL Horley Surrey | England | British | 124679050001 | |||||
| CLARK, Leslie Gordon | Administrateur | Wycherley 9 Deepdene Wood RH5 4BG Dorking Surrey England | British | 47781160001 | ||||||
| COCKELL, Aaron Colin | Administrateur | 98 Hopgarden Road TN10 4QU Tonbridge | England | British | 105928460001 | |||||
| COOPER, Audrey Lorina Tunnadine | Administrateur | White Lodge 2a Downs Road KT18 5HE Epsom Surrey | British | 50640690001 | ||||||
| CORNELIUS, Anthony John | Administrateur | The Lodge Cockcrow Hill St Marys Road KT6 5HE Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 122354980003 | |||||
| DALY, Terence Patrick | Administrateur | Lucastes Hacketts Lane Pyrford GU22 8PJ Woking Surrey | British | 29147000001 | ||||||
| DEAL, Janet Ann | Administrateur | Dingwall Cottage Edwin Road KT24 6LN West Horsley Surrey | Great Britain | British | 93239360001 | |||||
| FUNNING, Elizabeth Ann | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 84100800001 | |||||
| GORDON, Peter David | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 83945740001 | |||||
| GRANT, Julia Catherine | Administrateur | Elmtrees Oakcroft Road KT14 6JH West Byfleet Surrey | British | 60020110001 | ||||||
| HANNAM, Paul David | Administrateur | Westaway Westbrook Road GU7 2QH Godalming Surrey | British | 30060950009 | ||||||
| HOWARD, Christine Jane, Councillor | Administrateur | 2 Holly Cottage Wonersh Common Road GU5 0PL Wonersh | England | British | 72269300002 | |||||
| HUTCHINS, Janice | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 275332280001 | |||||
| JEFFERY, Joanna Lesley | Administrateur | Gowdhurst Chart Lane RH4 2BU Dorking Surrey | England | British | 122223930001 | |||||
| JONES, Edwin John | Administrateur | 158 High Street GU22 9JH Old Woking Surrey | British | 83515480001 | ||||||
| JOSH, Jo | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 173341120001 | |||||
| KEARNEY, Mary Alison | Administrateur | Broomacre Station Road Chobham GU24 8AZ Woking Surrey | British | 34522780001 | ||||||
| KEELEY, Alison Jane | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 308366240001 | |||||
| KORTENRAY, Elliot Ben | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 268936220002 | |||||
| KUSAR, Khalda Jabeen | Administrateur | Astolat Coniers Way New Inn Lane Burpham GU4 7HL Guildford Surrey | England | British | 161332440001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SURREY COMMUNITY ACTION ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 23 mai 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0