LEEDS LOFT COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEEDS LOFT COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03203116
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEEDS LOFT COMPANY LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe LEEDS LOFT COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LEEDS LOFT COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour LEEDS LOFT COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report bdd 13/08/2015
    6 pagesLIQ MISC

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 21 nov. 2014

    2 pages3.6

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:progress report
    6 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Changement d'adresse du siège social de * the Office Simpsons Fold 22 Dock Street Leeds LS10 1JF* le 20 août 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2010

    4 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juin 2011

    État du capital au 08 juin 2011

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Loft International Ltd le 23 mai 2011

    2 pagesCH04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Loft International Ltd le 23 mai 2010

    2 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de * Shears Yard 21 Wharf Street the Calls Leeds West Yorkshire LS2 7EQ* le 18 mars 2010

    2 pagesAD01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    4 pages395

    Qui sont les dirigeants de LEEDS LOFT COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOFT INTERNATIONAL LTD
    Simpsons Fold
    22 Dock Street
    LS10 1JF Leeds
    The Office
    Secrétaire
    Simpsons Fold
    22 Dock Street
    LS10 1JF Leeds
    The Office
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04224395
    128816650001
    MACLEAN, Dennis
    32 Simpsons Fold
    22 Dock Street
    LS10 1JF Leeds
    Administrateur
    32 Simpsons Fold
    22 Dock Street
    LS10 1JF Leeds
    United KingdomBritish37460890003
    COCKRAM, Steven
    Apt 74 Cromwell Court
    Brewery Wharf, Bowman Lane
    LS10 1HN Leeds
    Secrétaire
    Apt 74 Cromwell Court
    Brewery Wharf, Bowman Lane
    LS10 1HN Leeds
    British83722290002
    MACLEAN, Pauline Theresa
    Old Pool Bank
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EJ Otley
    Pool Hall
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Old Pool Bank
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EJ Otley
    Pool Hall
    West Yorkshire
    British129092480001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Secrétaire désigné
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Administrateur désigné
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    LEEDS LOFT COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 18 mars 2009
    Livré le 26 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    25 shafton lane leeds; together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 03 juin 2005
    Livré le 10 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all that f/h land and building thereon erected and generally k/a 25 shafton lane leeds west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National PLC
    Transactions
    • 10 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 305 déc. 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 310 déc. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 3
    Legal and general charge
    Créé le 03 juin 2005
    Livré le 10 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings thereon erected and generally k/a 25 shafton lane leeds west yorkshire by way of fixed and floating charge other property at any time hereafter vested in the company all uncalled capital for the time being all intellectual property rights all other f/h and l/h property now or in the future in which the company have or acquire any legal or beneficial interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National PLC
    Transactions
    • 10 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 21 févr. 2005
    Livré le 23 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Rights, title and interests in, to and under north speed house moor view leeds, monies standing to the credit of any company, goodwill of any business, agreements contracts deeds licences by way of floating charge all present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commercial First Securities Limited
    Transactions
    • 23 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land on the east side of ingram road holbeck leeds.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 205 déc. 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 210 déc. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 2
    Legal and general charge
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings land on the east side of ingram road holbeck leeds and also k/a ashton tools middle works ingram road holbeck leeds. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 16 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a 83A otley road,leeds.t/no.WYK492736.by way of assignment the goodwill of the business.the benefit of the licences.floating charge the undertaking of the company and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 16 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 avr. 1998
    Livré le 01 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a 28 dock street leeds west yorkshire t/n-WYK222574. By way of assignment the goodwill of the business, the benefit of the licences and the benefits respectively carried on or arising in respect of the property provided that the same shall be reassigned on repayment of the secured amounts.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 01 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over building contract
    Créé le 08 janv. 1998
    Livré le 12 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in and to a building contract dated 31ST october 1997 including all claims for damages and the right to receive and demand payment of any monies payable under or in connection with the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 12 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge with floating charge
    Créé le 08 janv. 1998
    Livré le 12 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a 24,26,26A and 28A dock street leeds west yorkshire t/no.WYK423623 and WYK244106 by way of assignment of the goodwill of the business and benefit of licences. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights present and future.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 12 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LEEDS LOFT COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 oct. 2016Conclusion of winding up
    09 janv. 2013Petition date
    25 mars 2013Commencement of winding up
    20 janv. 2017Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Leeds
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    practitioner
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    James Richard Duckworth
    Freeman Rich
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire
    practitioner
    Freeman Rich
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Robert Acland
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    receiver manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Steven John Williams
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    receiver manager
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Robert Acland
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    receiver manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Steven John Williams
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    receiver manager
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0