POWERMARQUE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOWERMARQUE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03204406
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POWERMARQUE LIMITED ?

    • (5010) /
    • (5020) /

    Où se situe POWERMARQUE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POWERMARQUE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEVRUS (680) LIMITED28 mai 199628 mai 1996

    Quels sont les derniers comptes de POWERMARQUE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour POWERMARQUE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 juin 2004

    19 pagesAA

    legacy

    3 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    1 pages225

    legacy

    7 pages395

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de POWERMARQUE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    English94987030001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    Secrétaire
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Administrateur
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomEnglish94987030001
    VENSON GROUP PLC
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Administrateur
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    119183190001
    VENSON HOLDINGS LIMITED
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Administrateur
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    116764790001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    LAW, Stuart Peter
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    Secrétaire désigné
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    British900005090001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    DALY, James
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    British62710230001
    DICKINSON, Roger Martin
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    Administrateur
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    British91579530001
    DOONEY, Michael Martin
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    Administrateur
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    Irish68419160001
    DUNNE, Matthew
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British80391440001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Administrateur
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Administrateur
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    GIBBONS, David Victor
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    Administrateur désigné
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    British900005080001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    Administrateur
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    MELLOR, Christopher John
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    Administrateur
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    United KingdomUk97680390001
    PETTIFOR, Timothy John
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish40366940001
    SCRIVEN, Grant John Paul
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    Administrateur
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    United KingdomIrish28260840002
    WATSON, Charles Dishington
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish41054110001
    WILLIAMSON, Alister Wallace
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    British29612530001

    POWERMARQUE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Account charge
    Créé le 07 oct. 2004
    Livré le 20 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the deposit and all the entitlements to interest the rights to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 19 déc. 2003
    Livré le 09 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the goods, vehicles and equipment details of which are set our in the sale afgreement, together with the operating instructions, handbooks, specifications and books pertaining thereto and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Lease UK Limited
    Transactions
    • 09 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment
    Créé le 19 déc. 2003
    Livré le 09 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right, title, benefit and interest, present and future, under or arising out of or in respect of the relevant agreements; in, to and in respect of the vehicles the subject of the relevant agreements; in, to and in respect of all and any proceeds of claims made under the insurance in respect of the vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Lease UK Limited
    Transactions
    • 09 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0