PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03204842 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ?
Adresse du siège social | 1st Floor Health Aid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow Middlesex |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 24 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 30 sept. 2023 | 16 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2022 | 16 pages | AA | ||
Nomination de Ms Laxmi Sivasubramanian en tant que secrétaire le 05 août 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Robert Jeffrey Piper en tant que secrétaire le 05 août 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2021 | 15 pages | AA | ||
Satisfaction de la charge 032048420017 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 032048420018 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 032048420019 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 032048420020 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 032048420021 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2020 | 12 pages | AA | ||
Nomination de Mr Allan Howard Kay en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2019 | 12 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2018 | 12 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathan Rubins le 10 mai 2018 | 2 pages | CH01 | ||
Inscription de la charge 032048420020, créée le 13 avr. 2018 | 7 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge 032048420021, créée le 13 avr. 2018 | 7 pages | MR01 | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2017 | 12 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVASUBRAMANIAN, Laxmi | Secrétaire | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | 299635790001 | |||||||
KAY, Allan Howard | Administrateur | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | England | British | Director | 51275610001 | ||||
MELLER, Stephen Daniel | Administrateur | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | England | British | Finance Broker | 70938260003 | ||||
RUBINS, Brian Leslie | Administrateur | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex United Kingdom | England | British | Company Director | 95281890005 | ||||
RUBINS, Jonathan | Administrateur | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | England | British | Company Director | 118928320001 | ||||
FISK, Claire | Secrétaire | 7 Baldock Road SG6 3LB Letchworth Hertfordshire | British | 121524350001 | ||||||
KEEN, Frances Betty | Secrétaire | 9 Springfield Road NW8 0QJ London | British | 10151630001 | ||||||
NYKERK, Gerald David | Secrétaire | 44 St Clements Drive SS9 3BJ Leigh On Sea Essex | British | 17761620001 | ||||||
PIPER, Robert Jeffrey | Secrétaire | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex England | British | 95275260001 | ||||||
RUBINS, Jonathan | Secrétaire | 5 Manor Close SG6 3NN Letchworth Garden City Hertfordshire | British | 118928320001 | ||||||
WOOD, Maurice Thomas | Secrétaire | 10 Wellington Court Shelton Street WC2H 9JS London | British | 32560410001 | ||||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
SOUTHERN FUNDING LIMITED | Secrétaire | 94-96 Wigmore Street W1U 3RQ London | 47608700002 | |||||||
KEEN, Howard Ramon | Administrateur | Bessemer Drive SG1 2DX Stevenage Business And Technology Centre, Suite F8 Hertfordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 35540650005 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative Bridging Corporation Limited | 06 avr. 2016 | Healthaid House Marlborough Hill HA1 1UD Harrow 1st Floor Middlesex United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PROPERTY FINANCE NOMINEES (NO.3) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 13 avr. 2018 Livré le 16 avr. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Brève description N/A. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 13 avr. 2018 Livré le 16 avr. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Brève description N/A. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 29 sept. 2015 Livré le 07 oct. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description None. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 29 sept. 2015 Livré le 07 oct. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description None. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 29 sept. 2015 Livré le 07 oct. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description None. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-charge | Créé le 01 avr. 2011 Livré le 15 avr. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A mortgage of the property k/a 1 azure court doxford park sunderland and all principal interest or other money now and in the future secured by the mortgage together with the benefit of any other security now and in the future held for some indebtedness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-mortgage | Créé le 02 juil. 2003 Livré le 16 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti £2,600,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Land and buildings on the south west side of mirabel street, cheetham, manchester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-charge | Créé le 20 juin 2003 Livré le 01 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti £229,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 22 college road (formerly k/a land and buildings on the north side of college road) cheshunt, hertfordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-mortgage | Créé le 07 déc. 2001 Livré le 19 déc. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The property known as 5 broomleigh, booth road, altrincham, cheshire and garage. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub charge | Créé le 27 oct. 2001 Livré le 31 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti £261,000 due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Charge dated 27TH october 2001 relating to 24 petersham place london SW7. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Subcharge | Créé le 15 août 2001 Livré le 01 sept. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti £259,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Charge dated 15 august 2001 relating to 18/21 kings park road southampton t/no: HP104413. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-mortgage | Créé le 06 juin 2000 Livré le 15 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 5 st johns villas marloes road W8 and parking space 194 and 195 marloes road W8. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-charge | Créé le 10 nov. 1999 Livré le 19 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti £500,000 due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 14TH june 1999 | |
Brèves mentions Units 17 & 18 octavian way team valley gateshead. Units 21 & 22 park view industrial estate hartlepool. Units 7-26 kingsway team valley gateshead. Viscount house queensway enterprise estate scunthorpe. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-charge | Créé le 08 oct. 1999 Livré le 15 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti The principal monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 17TH september 1999 | |
Brèves mentions Flat 75 william court 6 hall road london NW8. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub-charge | Créé le 07 sept. 1999 Livré le 18 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti £56,700 due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 3 march 1999 | |
Brèves mentions Hereby charge the charge dated with even date herewith and the principal monies secured by that charge and all interest upon it due or about to become due and the benefit of all securities. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 15 juil. 1999 Livré le 30 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti £29,400.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter 3 march 1998 | |
Brèves mentions The property known as 40 thackeray avenue, tottenham london N17. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 25 mai 1999 Livré le 10 juin 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti £65,100 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 209 ribblesdale road SW16 6QS was charged by a charge dated 25/5/99. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 19 avr. 1999 Livré le 30 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti £504,000 due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Legal charge dated 19TH april 1999 relating to property at 493, 495, 497 & 499 watford way mill hill l/b of barnet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub charge | Créé le 16 avr. 1998 Livré le 22 avr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti The principal sum of £450,000 together with interest due or to become due from the company to the chargee in accordance with thefacility letter dated 27/02/98 | |
Brèves mentions The charge dated 16/04/98 and the principal monies secured by that charge and all interest due upon it and the benefit of all securities. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Sub charge | Créé le 23 mars 1998 Livré le 27 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti £165,900 due from the company to the chargee in accordance with the facility letter dated 27TH february 1998 from the lender to the company together with interest thereon | |
Brèves mentions The charge dated 23RD march 1998 and the principal monies secured by that charge and all interest due or to become due upon it and the benefit of all securities. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 mars 1998 Livré le 17 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0