WILLMOT PERTWEE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WILLMOT PERTWEE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03206948 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WILLMOT PERTWEE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Station Road Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WILLMOT PERTWEE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour WILLMOT PERTWEE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 18 févr. 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2021 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2020 | 17 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Stephen Matthews en tant que directeur le 27 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2019 | 18 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Reid en tant qu'administrateur le 19 nov. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Michael Dunne en tant que directeur le 19 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2018 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Marshall Rennie en tant qu'administrateur le 20 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter Dunne en tant qu'administrateur le 28 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Imelda Hurley en tant que directeur le 28 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2017 | 17 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Declan Patrick Giblin en tant que directeur le 21 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Stewart Downie en tant que directeur le 24 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WILLMOT PERTWEE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Spencer Gareth | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | England | British | 227570820001 | |||||
| HUGHES, Ronan Andrew | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | Irish | 164466890001 | |||||
| REID, Neil | Administrateur | Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 4-6 D24 Dcw0 Ireland | Ireland | Irish | 266176680001 | |||||
| RENNIE, James Marshall | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | United Kingdom | British | 245275770001 | |||||
| BADBERG, Sue Ellen | Secrétaire | 1245 North 13th Street 68410 Nebraska City Nebraska Usa | British | 47974150003 | ||||||
| BRENNAN, Thomas Patrick | Secrétaire | 1 Penrwyn Court PE19 2SU St Neots Cambridgeshire | British | 202542640001 | ||||||
| MURRAY, David Souter | Secrétaire | . GL54 4LZ Cheltenham Andoversford Gloucestershire United Kingdom | 164578240001 | |||||||
| RB SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire désigné | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006270001 | |||||||
| BOLDING, Jay Douglas | Administrateur | 3325 North 134 Circle Omaha Nebraska 68164 Usa | American | 65252730002 | ||||||
| BROWN, Richard | Administrateur | Manor Farmhouse Manor Farm, Eddlethorpe YO17 9QT Malton North Yorkshire | United Kingdom | British | 111686890001 | |||||
| CASEY, Walter | Administrateur | 414 Martin Drive North Bellevue 68005 Nebraska Usa | Amercian | 50862220001 | ||||||
| DERBYSHIRE, Stephen | Administrateur | The Gables Pump Lane, Fenton NG23 5DF Newark Nottinghamshire | England | British | 64532980001 | |||||
| DIFONZO, Kenneth Wayne | Administrateur | 16646 Howard Circle Omaha 68118 Nebraska Usa | Us Citizen | 40453120001 | ||||||
| DOWNIE, David Stewart | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | England | British | 101857040001 | |||||
| DUNNE, Peter Michael | Administrateur | Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 4-6 Ireland | Ireland | Irish | 296556910001 | |||||
| FITZGERALD, Brendan | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | Ireland | Irish | 142986030014 | |||||
| GIBLIN, Declan Patrick | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | Irish | 33529010002 | |||||
| HECKMAN, Gregory Allen | Administrateur | 6711 Davenport Street Omaha Nebraska 681342 Usa | American | 90638610004 | ||||||
| HURLEY, Imelda | Administrateur | Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 4-6 Ireland | Ireland | Irish | 190470420004 | |||||
| JOHNSON, Owen Charles | Administrateur | 1117 South 113th Court Omaha Nebraska 68144 U S A | U S Citizen | 98512790001 | ||||||
| MATTHEWS, Christopher Stephen | Administrateur | Dale Farm Collingham Road LN6 9JB Swinderby Lincolnshire | England | British | 104573600001 | |||||
| MCKINNERNEY, Floyd | Administrateur | 9309 Fm 462 North Hondo Texas 78861 Usa | American | 48604900002 | ||||||
| MESSEL, Scott Edward | Administrateur | 1124 South 113th Court Omaha Nebraska 68144 U S A | Usa | U S Citizen | 98512890001 | |||||
| MURRAY, David | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | British | 25241430001 | |||||
| O'DONNELL, James Patrick | Administrateur | 1126 S 181 Plaza Omaha Nebraska 68130 U.S.A | Us Citizen | 57520090002 | ||||||
| PRIESTLEY, Richard Paul | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | United Kingdom | British | 138721210001 | |||||
| ROBERTS, Jamie | Administrateur | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | British | 176036360001 | |||||
| SHARP, Barry John | Administrateur | The Old Orchard Bekesbourne Lane Bekesbourne CT4 5DY Canterbury Kent | England | British | 35545820002 | |||||
| THOMAS, Lawrence Bruce | Administrateur | 7813 Pierce Omaha 68124 Nebraska United States Of America | United States | 75675670003 | ||||||
| RB DIRECTORS ONE LIMITED | Administrateur désigné | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006260001 | |||||||
| RB DIRECTORS TWO LIMITED | Administrateur désigné | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006250001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WILLMOT PERTWEE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleancrop Uk Limited | 06 avr. 2016 | Station Road Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Agrii England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
WILLMOT PERTWEE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 18 avr. 2008 Livré le 29 avr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| All assets debenture | Créé le 28 avr. 2005 Livré le 07 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 28 avr. 2005 Livré le 05 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a or being land and buildings on the east side of gorse lane harlaxton linciolnshire t/no LL59771 all book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 28 avr. 2005 Livré le 05 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a or being land and buildings on the west side of asperton road wigtoft lincolnshire t/no LL117979. All book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0