WILLMOT PERTWEE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLMOT PERTWEE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03206948
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLMOT PERTWEE LIMITED ?

    • Activités de soutien à la production végétale (01610) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe WILLMOT PERTWEE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WILLMOT PERTWEE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CELANDOR LIMITED03 juin 199603 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de WILLMOT PERTWEE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLMOT PERTWEE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    État du capital au 18 févr. 2022

    • Capital: GBP 0.50
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2021

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2020

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Stephen Matthews en tant que directeur le 27 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2019

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Reid en tant qu'administrateur le 19 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Michael Dunne en tant que directeur le 19 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2018

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr James Marshall Rennie en tant qu'administrateur le 20 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter Dunne en tant qu'administrateur le 28 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Imelda Hurley en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2017

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Declan Patrick Giblin en tant que directeur le 21 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Stewart Downie en tant que directeur le 24 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de WILLMOT PERTWEE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EVANS, Spencer Gareth
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    EnglandBritish227570820001
    HUGHES, Ronan Andrew
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandIrish164466890001
    REID, Neil
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    D24 Dcw0
    Ireland
    Administrateur
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    D24 Dcw0
    Ireland
    IrelandIrish266176680001
    RENNIE, James Marshall
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United KingdomBritish245275770001
    BADBERG, Sue Ellen
    1245 North 13th Street
    68410 Nebraska City
    Nebraska
    Usa
    Secrétaire
    1245 North 13th Street
    68410 Nebraska City
    Nebraska
    Usa
    British47974150003
    BRENNAN, Thomas Patrick
    1 Penrwyn Court
    PE19 2SU St Neots
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    1 Penrwyn Court
    PE19 2SU St Neots
    Cambridgeshire
    British202542640001
    MURRAY, David Souter
    .
    GL54 4LZ Cheltenham
    Andoversford
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    .
    GL54 4LZ Cheltenham
    Andoversford
    Gloucestershire
    United Kingdom
    164578240001
    RB SECRETARIAT LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Secrétaire désigné
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006270001
    BOLDING, Jay Douglas
    3325 North 134 Circle
    Omaha
    Nebraska 68164
    Usa
    Administrateur
    3325 North 134 Circle
    Omaha
    Nebraska 68164
    Usa
    American65252730002
    BROWN, Richard
    Manor Farmhouse
    Manor Farm, Eddlethorpe
    YO17 9QT Malton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Manor Farmhouse
    Manor Farm, Eddlethorpe
    YO17 9QT Malton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish111686890001
    CASEY, Walter
    414 Martin Drive North
    Bellevue
    68005 Nebraska
    Usa
    Administrateur
    414 Martin Drive North
    Bellevue
    68005 Nebraska
    Usa
    Amercian50862220001
    DERBYSHIRE, Stephen
    The Gables
    Pump Lane, Fenton
    NG23 5DF Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Gables
    Pump Lane, Fenton
    NG23 5DF Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish64532980001
    DIFONZO, Kenneth Wayne
    16646 Howard Circle
    Omaha
    68118 Nebraska
    Usa
    Administrateur
    16646 Howard Circle
    Omaha
    68118 Nebraska
    Usa
    Us Citizen40453120001
    DOWNIE, David Stewart
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    EnglandBritish101857040001
    DUNNE, Peter Michael
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    Administrateur
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    IrelandIrish296556910001
    FITZGERALD, Brendan
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    IrelandIrish142986030014
    GIBLIN, Declan Patrick
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandIrish33529010002
    HECKMAN, Gregory Allen
    6711 Davenport Street
    Omaha
    Nebraska 681342
    Usa
    Administrateur
    6711 Davenport Street
    Omaha
    Nebraska 681342
    Usa
    American90638610004
    HURLEY, Imelda
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    Administrateur
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    IrelandIrish190470420004
    JOHNSON, Owen Charles
    1117 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    Administrateur
    1117 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    U S Citizen98512790001
    MATTHEWS, Christopher Stephen
    Dale Farm
    Collingham Road
    LN6 9JB Swinderby
    Lincolnshire
    Administrateur
    Dale Farm
    Collingham Road
    LN6 9JB Swinderby
    Lincolnshire
    EnglandBritish104573600001
    MCKINNERNEY, Floyd
    9309 Fm 462 North
    Hondo
    Texas 78861
    Usa
    Administrateur
    9309 Fm 462 North
    Hondo
    Texas 78861
    Usa
    American48604900002
    MESSEL, Scott Edward
    1124 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    Administrateur
    1124 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    UsaU S Citizen98512890001
    MURRAY, David
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish25241430001
    O'DONNELL, James Patrick
    1126 S 181 Plaza
    Omaha
    Nebraska 68130
    U.S.A
    Administrateur
    1126 S 181 Plaza
    Omaha
    Nebraska 68130
    U.S.A
    Us Citizen57520090002
    PRIESTLEY, Richard Paul
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United KingdomBritish138721210001
    ROBERTS, Jamie
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish176036360001
    SHARP, Barry John
    The Old Orchard
    Bekesbourne Lane Bekesbourne
    CT4 5DY Canterbury
    Kent
    Administrateur
    The Old Orchard
    Bekesbourne Lane Bekesbourne
    CT4 5DY Canterbury
    Kent
    EnglandBritish35545820002
    THOMAS, Lawrence Bruce
    7813 Pierce
    Omaha 68124
    Nebraska
    United States Of America
    Administrateur
    7813 Pierce
    Omaha 68124
    Nebraska
    United States Of America
    United States75675670003
    RB DIRECTORS ONE LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Administrateur désigné
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006260001
    RB DIRECTORS TWO LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Administrateur désigné
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006250001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WILLMOT PERTWEE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Agrii
    England
    06 avr. 2016
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Agrii
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05300865
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WILLMOT PERTWEE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 avr. 2008
    Livré le 29 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 07 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 07 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 05 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being land and buildings on the east side of gorse lane harlaxton linciolnshire t/no LL59771 all book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 05 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being land and buildings on the west side of asperton road wigtoft lincolnshire t/no LL117979. All book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0