NETWORK I LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNETWORK I LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03208037
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NETWORK I LIMITED ?

    • Autres activités de télécommunications (61900) / Information et communication

    Où se situe NETWORK I LIMITED ?

    Adresse du siège social
    227 Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NETWORK I LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERNET SERVICE PROVIDERS CONSORTIUM LIMITED05 juin 199605 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de NETWORK I LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour NETWORK I LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Ms Vanessa Rachel Candela en tant qu'administrateur le 28 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Janet Bawcom Wright en tant qu'administrateur le 28 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen John Webber en tant que directeur le 01 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Thomas Dacier en tant que directeur le 07 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2016 au 31 janv. 2017

    1 pagesAA01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2016

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2016

    État du capital au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 3,400
    SH01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 08 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium a/c 31/12/2015
    RES13

    Cessation de la nomination de Michael John Provenzano en tant que directeur le 22 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen John Webber en tant qu'administrateur le 22 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Thomas Dacier en tant qu'administrateur le 22 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 22/01/2016
    RES13

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032080370009 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032080370010 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de NETWORK I LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REID, Kevin
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    167357660001
    CANDELA, Vanessa Rachel
    Primrose Street
    EC2A 2EG London
    Herbert Smith Freehills Llp, Exchange House
    England
    Administrateur
    Primrose Street
    EC2A 2EG London
    Herbert Smith Freehills Llp, Exchange House
    England
    UsaAmericanLawyer224179670001
    REID, Kevin
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    UsaAmericanCeo, Cto165174820001
    ROGERS, Rodney John
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    United StatesAmericanCeo165174830001
    WRIGHT, Janet Bawcom
    Primrose Street
    EC2A 2EG London
    Herbert Smith Freehills, Exchange House
    England
    Administrateur
    Primrose Street
    EC2A 2EG London
    Herbert Smith Freehills, Exchange House
    England
    United Sates Of AmericaAmericanLawyer131517960001
    BROUGH, Stuart John
    Settle
    12 Hedgerley Lane
    SL9 7NS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Settle
    12 Hedgerley Lane
    SL9 7NS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishAccountant103686820001
    REYNOLDS, Barry John
    17 Cresswells Mead
    Holyport
    SL6 2YP Maidenhead
    Berks
    Secrétaire
    17 Cresswells Mead
    Holyport
    SL6 2YP Maidenhead
    Berks
    BritishAccountant33545480001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    AZAR, Alberto Edwardo
    27 Warwick Avenue
    W9 2PS London
    Administrateur
    27 Warwick Avenue
    W9 2PS London
    EnglandArgentinianStrategic Development Director82631580001
    DACIER, Paul Thomas
    176 South Street
    Hopkinton
    Emc Corporation
    Massachusets
    Usa
    Administrateur
    176 South Street
    Hopkinton
    Emc Corporation
    Massachusets
    Usa
    United States Of AmericaUnited StatesDirector68808290001
    KELLY, Brian-Seamus
    47 Curzon Street
    Mayfair
    London
    Administrateur
    47 Curzon Street
    Mayfair
    London
    IrishChartered Accountant51614070001
    MCKEOWN, Gerry
    61 Marbella Country Club Super H
    Nuava Andalcia
    FOREIGN Marbella
    Malaga 29660
    Spain
    Administrateur
    61 Marbella Country Club Super H
    Nuava Andalcia
    FOREIGN Marbella
    Malaga 29660
    Spain
    IrishCompany Director88601160001
    MOORES, Gerwyn William
    7 Suncroft Close
    Woolston
    WA1 4DQ Warrington
    Administrateur
    7 Suncroft Close
    Woolston
    WA1 4DQ Warrington
    BritishConsultant68260360002
    PROVENZANO, Michael John
    Montgomery Lane
    Suite 1100
    Maryland
    4800
    Usa
    Administrateur
    Montgomery Lane
    Suite 1100
    Maryland
    4800
    Usa
    United StatesAmericanChief Financial Officer177123910001
    REYNOLDS, Barry John
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Berwick Avenue
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    England
    EnglandBritishAccountant33545480001
    ROLFE, Andrew John
    52 Mount Park Road
    W5 2RU London
    Administrateur
    52 Mount Park Road
    W5 2RU London
    BritishTechnical Manager63725220001
    SHARMA, Sandeep Kumar, Mr.
    Berwick Avenue
    Datchet
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Berwick Avenue
    Datchet
    SL1 4QT Slough
    227
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector58503880002
    TSANG, David Eric
    5 Porthcawl Close
    Cromton
    WA8 9FE Widnes
    Cheshire
    Administrateur
    5 Porthcawl Close
    Cromton
    WA8 9FE Widnes
    Cheshire
    BritishCommunications78029580001
    WEBBER, Stephen John
    228 South Street
    Hopkinton
    Virtustream Inc
    Massachusetts
    Usa
    Administrateur
    228 South Street
    Hopkinton
    Virtustream Inc
    Massachusetts
    Usa
    Usa MassachusettsAmericanDirector256841020001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    NETWORK I LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 avr. 2013
    Livré le 26 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Orix Ventures Llc
    Transactions
    • 26 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 24 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 avr. 2013
    Livré le 23 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 23 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental charge
    Créé le 26 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all book debts, the benefit of all guarantees and securities and all other debts and monetary claims see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Orix Ventures Llc
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 12 juin 2009
    Livré le 18 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Finance South East Limited
    Transactions
    • 18 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 juin 2008
    Livré le 12 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 10 nov. 2003
    Livré le 11 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things, schedule: forgent video management system including alliance suite serial number: NI29O7O3 or any part thereof.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 11 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 21 juin 2002
    Livré le 21 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Configured-MGC100 mix s/no. 2099.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 21 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deposit deed
    Créé le 10 déc. 1999
    Livré le 15 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brèves mentions
    The sum of £29,971.00 in an interest earning account together with the amount from time to time standing to the credit of such account.
    Personnes ayant droit
    • Slough Trading Estate Limited
    Transactions
    • 15 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0