APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED

APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAPM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03208744
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED ?

    • Activités de conseil en gestion autres que la gestion financière (70229) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor 18 Mansell Street
    E1 8AA London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PERTEMPS DISABILITY CONSULTANCY LIMITED15 mars 200815 mars 2008
    PERTEMPS PEOPLE DEVELOPMENT LTD05 févr. 200705 févr. 2007
    PERTEMPS PEOPLE DEVELOPMENT GROUP HOLDINGS LIMITED19 févr. 200419 févr. 2004
    PERTEMPS PEOPLE DEVELOPMENT GROUP LIMITED20 févr. 200320 févr. 2003
    PERTEMPS TRAINING AND CONSULTANCY LIMITED22 oct. 199622 oct. 1996
    PERTEMPS TRAINING BUREAU LIMITED01 oct. 199601 oct. 1996
    REFINEBEFORE LIMITED06 juin 199606 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 032087440014 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032087440015 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    3 pagesAA

    Inscription de la charge 032087440014, créée le 24 sept. 2020

    62 pagesMR01

    Inscription de la charge 032087440015, créée le 24 sept. 2020

    62 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 032087440013 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032087440010 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032087440012 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032087440011 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Alan Cave en tant que directeur le 21 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    2 pagesAA

    Inscription de la charge 032087440013, créée le 13 déc. 2019

    53 pagesMR01

    Inscription de la charge 032087440012, créée le 24 oct. 2019

    53 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gregory Harold Meyerowitz le 27 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gregory Harold Meyerowitz le 26 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gregory Harold Meyerowitz le 26 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Megan Kyla Wynne en tant que directeur le 28 août 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Carla Raffinetti en tant que secrétaire le 22 août 2019

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Apm Unit 40, Newtown Shopping Centre Newtown Birmingham B19 2SS United Kingdom à 5th Floor 18 Mansell Street London E1 8AA le 28 mai 2019

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAFFINETTI, Carla
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    Secrétaire
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    261751740001
    MEYEROWITZ, Gregory Harold
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    AustraliaAustralianFinance Director254156390001
    DUDLEY, Nigel John
    106 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DQ Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    106 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DQ Solihull
    West Midlands
    British45866830002
    JACKSON, Jennifer Anne
    Glebe Barn
    Morton Wood Lane
    WR7 4LU Abbots Morton
    Worcester
    Secrétaire
    Glebe Barn
    Morton Wood Lane
    WR7 4LU Abbots Morton
    Worcester
    British17906250002
    MYTTON, Jill
    Highview Farm, Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    Shropshire
    Secrétaire
    Highview Farm, Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    Shropshire
    British69055850001
    WATTS, Timothy
    Aspley House
    The Green Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    Aspley House
    The Green Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    BritishDirector153594880001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACON, Nigel Douglas
    Barn Cottage
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverton
    Warwickshire
    Administrateur
    Barn Cottage
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverton
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant151714900001
    BELLINGE, Bruce Stone
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    AustraliaAustralianDirector199867010001
    BIRCHALL, Colin
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director85397860001
    BIRCHALL, Colin
    96 Longwood Road
    WS9 0TD Aldridge
    West Midlands
    Administrateur
    96 Longwood Road
    WS9 0TD Aldridge
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director85397860001
    BORZILLO, Barry
    60 City Road
    Southbank
    C/O Level 20
    Victoria 30006
    Australia
    Administrateur
    60 City Road
    Southbank
    C/O Level 20
    Victoria 30006
    Australia
    AustraliaAustralianChief Executive Officer150539460001
    CAVE, Alan
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    EnglandBritishDirector42216510003
    EDWARDS, Gareth Russell
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector86275090001
    ENGLEFIELD, Roger
    Oxstalls
    The Green
    B94 5AL Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    Oxstalls
    The Green
    B94 5AL Tanworth In Arden
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director15067540009
    FIDDES, Paul
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    AustraliaAustralianCompany Director213217530001
    HOBDAY, Michael
    Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    17
    England
    Administrateur
    Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    17
    England
    AustraliaAustralianGroup Ceo199867650001
    JACKSON, Jennifer Anne
    Glebe Barn
    Morton Wood Lane
    WR7 4LU Abbots Morton
    Worcester
    Administrateur
    Glebe Barn
    Morton Wood Lane
    WR7 4LU Abbots Morton
    Worcester
    EnglandBritishCompany Director17906250002
    KING, Stephen Anthony
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector156718350001
    LEACH, Robert William
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector199866540001
    MYTTON, Jill
    Highview Farm, Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    Shropshire
    Administrateur
    Highview Farm, Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director69055850001
    NIXON, John Peter
    Highfields
    Packington Lane Hopwas
    B78 3AY Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    Highfields
    Packington Lane Hopwas
    B78 3AY Tamworth
    Staffordshire
    BritishCompany Director35985920003
    PORTER, John Charles
    3 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    3 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector55047310001
    RALSTON, Prins Aubrey
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Westbourne Road
    Edgbaston
    B15 3TR Birmingham
    Westbourne Manor
    United Kingdom
    AustralianChief Executive Officer133749390001
    RATCLIFFE, Alan
    117 The Common
    Earlswood
    B94 5SH Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    117 The Common
    Earlswood
    B94 5SH Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishManager60517840001
    ROBERTS, Edward John
    Church Farm
    Grafton Flyford
    WR7 4PG Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Church Farm
    Grafton Flyford
    WR7 4PG Worcester
    Worcestershire
    BritishCompany Director40253540001
    WATTS, Timothy
    Aspley House
    The Green Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Aspley House
    The Green Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director153594880001
    WYNNE, Megan Kyla
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    18 Mansell Street
    E1 8AA London
    5th Floor
    England
    AustraliaAustralianManaging Director199871620001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Advanced Personnel Management Holdings (Uk) Limited
    Newtown Shopping Centre
    B19 2SS Birmingham
    Unit 40,
    England
    18 mars 2019
    Newtown Shopping Centre
    B19 2SS Birmingham
    Unit 40,
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCorporations Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement06508998
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Advanced Personnel Management Group (Uk) Ltd
    Newtown Shopping Centre,
    B19 2SS Birmingham
    Unit 40
    England
    18 mars 2019
    Newtown Shopping Centre,
    B19 2SS Birmingham
    Unit 40
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCorporations Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement04881405
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Miss Megan Kyla Wynne
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Unit 40, Newtown Shopping Centre
    Newtown
    B19 2SS Birmingham
    Apm
    United Kingdom
    Oui
    Nationalité: Australian
    Pays de résidence: Australia
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    APM DISABILITY CONSULTANCY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 sept. 2020
    Livré le 09 oct. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 09 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 mars 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 sept. 2020
    Livré le 09 oct. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 09 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 mars 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 déc. 2019
    Livré le 16 déc. 2019
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cba Corporate Services (Nsw) Pty Limited
    Transactions
    • 16 déc. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 oct. 2019
    Livré le 01 nov. 2019
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cba Corporate Services (Nsw) Pty Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 05 déc. 2018
    Livré le 18 déc. 2018
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cba Corporate Services (Nsw) Pty Limited
    Transactions
    • 18 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 sept. 2017
    Livré le 26 sept. 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cba Corporate Services (Nsw) Pty Limited
    Transactions
    • 26 sept. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 oct. 2015
    Livré le 01 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Westpac Banking Corporation
    Transactions
    • 01 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 oct. 2008
    Livré le 15 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or employment services finance pty limited to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westpac Administration Pty Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 15 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 12TH september 2007 and
    Créé le 17 avr. 2008
    Livré le 22 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2008
    • 29 avr. 2008
    • 30 avr. 2008
    • 30 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 avr. 2008
    Livré le 22 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 12 september 2007 and
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 janv. 2004
    Livré le 24 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 févr. 1997
    Livré le 19 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Pertemps Group Limited
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0