EX-RCC SUB-CO LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EX-RCC SUB-CO LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03208807 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EX-RCC SUB-CO LIMITED ?
| Adresse du siège social | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EX-RCC SUB-CO LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 02 janv. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour EX-RCC SUB-CO LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Rushworth Smith en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Rollason en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Emerson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr William Rollason en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon George Rowe en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 29 juin 2010 au 29 déc. 2010 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Matthew Charles Emerson en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Hill en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 12 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 juin 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 22 juin 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 24 juin 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EX-RCC SUB-CO LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROWE, Simon George | Administrateur | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH | England | British | 68119020002 | |||||
| SMITH, Stephen Rushworth | Administrateur | Hatton Garden EC1N 8LE London 63-66 | United Kingdom | British | 6894950002 | |||||
| CROXFORD, John Robert | Secrétaire | Stanley Court Worcester Road SH2 6SD Sutton 18 Surrey | British | 139724880002 | ||||||
| GAMBLE, Stephen | Secrétaire | 92 Bressey Grove South Woodford E18 2HX London | British | 106836430001 | ||||||
| GARDNER, Douglas Charles | Secrétaire | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | 75225920001 | ||||||
| HOLDER, Ian Keith | Secrétaire | 39a Great Percy Street WC1X 9RD London | British | 60759970001 | ||||||
| LANGRIDGE, Megan Joy | Secrétaire | 42 Everest Drive Hoo St Werburgh ME3 9AW Rochester Kent | British | 86459820005 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Secrétaire | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | British | 62321110002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABRAHAM, Neville Victor | Administrateur | 82 Addison Road W14 8ED London | United Kingdom | British | 10579160002 | |||||
| BASING, Nicholas Andrew | Administrateur | Kinrara Cavendish Road KT13 0JW Weybridge Surrey | British | 89419000001 | ||||||
| DA COSTA, Michael Phillip | Administrateur | 43 Clifton Hill St John Wood NW8 0QE London | British | 26140900001 | ||||||
| DARWIN, Richard James | Administrateur | 25 Meadow Road KT10 0RZ Claygate Surrey | United Kingdom | British | 148079910001 | |||||
| EMERSON, Matthew Charles | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British | 61777750002 | |||||
| GARDNER, Douglas Charles | Administrateur | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | 75225920001 | ||||||
| HILL, Peter Martin | Administrateur | Silver Crescent W4 5SE London 8a | England | British | 130983750001 | |||||
| HOLDER, Ian Keith | Administrateur | Top Flats 55 Lexham Gardens W8 5JS London | British | 60759970002 | ||||||
| ISAACSON, Laurence Ivor | Administrateur | 5 Chalcot Crescent NW1 8YE London | United Kingdom | British | 2996380001 | |||||
| JOFFE, Russel | Administrateur | Apartment 203 Marine Heights 93 Ramatyam 46851 Herzliya Pituach Israel | British | 58916680002 | ||||||
| PAYMAN, Robert Alan | Administrateur | Amberley 11 Ferncroft Avenue NW3 7PG London | British | 61741360001 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Administrateur | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | England | British | 62321110002 | |||||
| ROLLASON, William | Administrateur | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH | United Kingdom | British | 140347580001 | |||||
| WILLIAMS, David Grey | Administrateur | Orchard House Shootersway Lane HP4 3NW Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 33840400001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
EX-RCC SUB-CO LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 18 févr. 1998 Livré le 05 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 17TH december 1997 | |
Brèves mentions Leasehold 171 piccadilly london W1.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture deed | Créé le 16 avr. 1997 Livré le 19 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0