PETROCELTIC RESOURCES LIMITED

PETROCELTIC RESOURCES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPETROCELTIC RESOURCES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03210072
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor, 10 Finsbury Square
    EC2A 1AF London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PETROCELTIC RESOURCES PLC19 août 201319 août 2013
    MELROSE RESOURCES PLC08 avr. 199808 avr. 1998
    MELROSE PETROLEUM GROUP LIMITED 07 avr. 199707 avr. 1997
    MELROSE PETROLEUM V LIMITED10 juin 199610 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    12 pagesAA

    Satisfaction de la charge 032100720043 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032100720046 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 mars 2021 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 111 Buckingham Palace Road Victoria London SW1W 0SR England à 83 Victoria Street London SW1H 0HW

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    18 pagesAA

    Modification des détails de Petroceltic Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 avr. 2019

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 23 mars 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 032100720045 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032100720044 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 032100720046, créée le 12 mars 2020

    41 pagesMR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 2nd Floor, Portland House Bressenden Place London SW1E 5RS England à 111 Buckingham Palace Road Victoria London SW1W 0SR

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Angelo Radostinov Moskov le 21 juin 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Denis Ischenko le 21 juin 2019

    2 pagesCH01

    Satisfaction de la charge 032100720042 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 10 Greycoat Place London SW1P 1SB à 2nd Floor, Portland House Bressenden Place London SW1E 5RS

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Joseph Lenihan Mulcahy en tant que directeur le 06 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILSON, Peter
    Collessie
    KY15 7RQ Cupar
    Thirlestane House
    Scotland
    Secrétaire
    Collessie
    KY15 7RQ Cupar
    Thirlestane House
    Scotland
    214876960001
    ISCHENKO, Denis
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    Administrateur
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    EnglandBritish209523810001
    MOSKOV, Angelo Radostinov
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    Administrateur
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    England
    United KingdomBritish158210200001
    LARSEN, Glynn Andrew
    55a Upper Montagu Street
    W1H 1FQ London
    Secrétaire
    55a Upper Montagu Street
    W1H 1FQ London
    British75432740003
    LOW, Sarah Rosemary Moir
    Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    19
    Midlothian
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    19
    Midlothian
    United Kingdom
    209425110001
    ROBINSON, Alasdair Nicholson
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Secrétaire
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    British99931280001
    THOMAS, Christopher Charles Arnold
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    Secrétaire
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    British45958770001
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Secrétaire désigné
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    TODS MURRAY LLP
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    1117600003
    ADAIR, Robert Fredrik Martin
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish141849580002
    AGNEW, James Douglas
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish126602000001
    ARCHER, David Fraser
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish49699910001
    CAMERON, Henry Ogilvy
    20 Wellbrae Terrace
    AB15 7XY Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    20 Wellbrae Terrace
    AB15 7XY Aberdeen
    Scotland
    British179510001
    CURRY, David William
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    Administrateur
    33 Atholl Crescent Lane
    EH3 8ET Edinburgh
    British57960560003
    FRASER, Diane Margaret Vivienne
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish192830550002
    HAY, James Taylor Cantlay
    67 Fountainhall Road
    AB2 4EU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    67 Fountainhall Road
    AB2 4EU Aberdeen
    Aberdeenshire
    British1206020001
    HICKEY, Thomas Gerard
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    IrelandIrish74548640003
    HUDSON, Kelvin Mark
    Le Manoir
    Ruette Des Effards, Castel
    GY5 7DQ Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Le Manoir
    Ruette Des Effards, Castel
    GY5 7DQ Guernsey
    Channel Islands
    GuernseyBritish75788480001
    KEBAILI, Ahmed L, Dr
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    FranceAmerican131407160002
    LANE, George
    11e/1 Ravelston Park
    EH4 3DX Edinburgh
    Administrateur
    11e/1 Ravelston Park
    EH4 3DX Edinburgh
    British19070490001
    MULCAHY, Joseph Lenihan
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandIrish209520250001
    O'CATHAIN, Brian John
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Ireland (Republic Of)Irish172956350001
    PARSLEY, Alan John, Dr
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    EnglandBritish135195050002
    RICHMOND-WATSON, Anthony Euan
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish1467180001
    SUTHERLAND, James Munro Murray
    14 Braid Avenue
    EH10 6EE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    14 Braid Avenue
    EH10 6EE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish243360001
    THOMAS, Christopher Charles Arnold
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    Administrateur
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    British45958770001
    THOMAS, Christopher Charles Arnold
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    Administrateur
    20 Hartismere Road
    SW6 7UD London
    British45958770001
    THOMAS, David Howard
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish65462550002
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish1604580001
    WYATT, William Penfold
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    19 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Exchange Tower
    Midlothian
    United Kingdom
    EnglandBritish87896480001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Administrateur désigné
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PETROCELTIC RESOURCES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sunny Hill Energy Limited
    Greycoat Place
    SW1P 1SB London
    10
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Greycoat Place
    SW1P 1SB London
    10
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Cardiff
    Numéro d'enregistrement9728547
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PETROCELTIC RESOURCES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 mars 2020
    Livré le 16 mars 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold and leasehold property in england & wales as more fully set out in the definition of "real property" in clause 1. "intellectual property" means any patents, trademarks etc as more fully defined in clause 1.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ploutos Agency Llc (As Security Agent)
    Transactions
    • 16 mars 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 déc. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2017
    Livré le 04 avr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ploutos Agency Llc
    Transactions
    • 04 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2017
    Livré le 04 avr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ploutos Agency Llc
    Transactions
    • 04 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2017
    Livré le 04 avr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold and leasehold property in england and wales as more fully set out in the definition of 'real property' in clause 1. intellectual property means any patents, trademarks etc. as more fully defined in clause 1.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ploutos Agency Llc
    Transactions
    • 04 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 déc. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 mars 2017
    Livré le 04 avr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ploutos Agency Llc
    Transactions
    • 04 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 janv. 2016
    Livré le 22 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 22 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 janv. 2016
    Livré le 25 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 25 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 janv. 2016
    Livré le 25 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 25 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 janv. 2016
    Livré le 22 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 22 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 sept. 2015
    Livré le 28 sept. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed security over all freehold and leasehold property in england and wales ('real property'); fixed security over any present or future intellectual property. For more details, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 28 sept. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 juil. 2015
    Livré le 20 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 20 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 juil. 2014
    Livré le 16 juil. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 16 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 20 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in melrose resources romania bv.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 20 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 20 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in melrose petroleum company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 20 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 20 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in melrose resources sarl.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 20 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 20 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Share charge dated 31/05/2013 over the shares in odyssey international petroleum LTD. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 20 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 13 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transactions
    • 13 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 mai 2013
    Livré le 15 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Security Trustee (UK) Limited
    Transactions
    • 15 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 24 oct. 2012
    Livré le 05 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first priority pledge on the pledged assets being all rights titles interests and benefit in to and under the shares and all distributions relating to the shares see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 05 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 07 févr. 2012
    Livré le 09 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in us dollars designated ltsb re melrose resources PLC and numbered 11701789 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Omnibus acknowledgement of security interests
    Créé le 23 juin 2008
    Livré le 08 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from grantors or any of them, to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company for the benefit of the secured creditors confirm all liens and security interests granted under the existing security documents shall continue. A lien on and security interest in all of the companys property and assets described in each existing security document see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent and Trustee (Bos)
    Transactions
    • 08 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Amendment agreement
    Créé le 23 juin 2008
    Livré le 08 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    As continuing security for the due and full payment, discharge and performance of all the secured obligations, the pledgor, as full and sole owner of shares, pledges it's right, title and interest to the shares to. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent of the Secured Creditors
    Transactions
    • 08 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Pledge amendment
    Créé le 23 juin 2008
    Livré le 08 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from obligors to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100,000 common shares in the capital of the issuer shall be and become part of the collateral referred to in the pledge agreement, pursuant to which the collateral is pledged in favour of the security agent see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Creditors
    Transactions
    • 08 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Pledge agreement
    Créé le 23 juin 2008
    Livré le 08 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from obligors to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    13,633 common shares in the issuer shall be and become part of the collateral referred to in the pledge agreement, pursuant to which the collateral is pledged in favour of the security agent see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Creditors
    Transactions
    • 08 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share charge
    Créé le 23 juin 2008
    Livré le 07 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares, all dividends or interest paid, all securities see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 07 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0