RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03210281 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 4 pages | 4.71 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Active House 21 North Fourth Street Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1HL* le 09 oct. 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Norman Field en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Antony Woolf en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Matthew Graham Merrick en tant qu'administrateur | 4 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de James Archibald en tant que secrétaire | 4 pages | AP03 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de James Archibald en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Matthew Graham Merrick en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 12 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew William Bucknall en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Norman Mark Field en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Trinity Court Molly Millars Lane Wokingham Berkshire RG41 2PY* le 08 sept. 2011 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Leatherbarrow en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIBALD, James | Secrétaire | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | British | 162966580001 | ||||||
| BUCKNALL, Matthew William | Administrateur | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | 162066820001 | |||||
| MERRICK, Matthew Graham | Administrateur | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | 162110530001 | |||||
| WOOLF, Paul Antony | Administrateur | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | 160679880001 | |||||
| ASHWORTH, Paul Richard | Secrétaire | 118 St Anns Hill Wandsworth SW18 2RR London | British | 46410260001 | ||||||
| BALL, Michael David | Secrétaire | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | British | 58961410002 | ||||||
| DREGENT, Patricia Ann Taylor | Secrétaire | 17 Spinney Close RM13 8LR Rainham Essex | British | 6369240002 | ||||||
| PARKES, Helen Katharine | Secrétaire | 22 Orchard Mead House 733 Finchley Road NW11 8DJ London | British | 48065800001 | ||||||
| PENRICE, Victoria Margaret | Secrétaire | Trebartha 51a Frances Road SL4 3AQ Windsor Berkshire | British | 90459300001 | ||||||
| SCALES, Eugene Patrick | Secrétaire | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | Other | 124193970001 | ||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Secrétaire | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Secrétaire | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | British | 113777700001 | ||||||
| WHEELER, Jonathan | Secrétaire | 19 Glebe Place Chelsea SW3 5LD London | British | 19812400001 | ||||||
| WONG, Wai Chung | Secrétaire | Flat 3 Rowsley Lodge 72a Lady Margaret Road N19 5EL London | British | 123616460002 | ||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Secrétaire désigné | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||
| ASHWORTH, Paul Richard | Administrateur | 118 St Anns Hill Wandsworth SW18 2RR London | England | British | 46410260001 | |||||
| BALL, Michael David | Administrateur | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 58961410002 | |||||
| BEADLE, Mark Ronald Sydney | Administrateur | 14 Fen Meadow TN15 9HT Ightham Kent | British | 80515670001 | ||||||
| CHARLTON, Stephen Paul | Administrateur | 9 Rowan Close L40 4LP Burscough Lancashire | England | British | 96743210001 | |||||
| CLELAND, Jonathan Bradley | Administrateur | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 146698270001 | |||||
| COLES, Charles Graham | Administrateur | Willow Cottage Chalfont Lane WD3 5PP Chorleywood Hertfordshire | England | British | 12337010002 | |||||
| CREED, Stuart John | Administrateur | Jade House The Avenue Claverton Down BA2 7AX Bath | United Kingdom | British | 3716600001 | |||||
| DHODY, Jog | Administrateur | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 104269910002 | |||||
| FIELD, Norman Mark | Administrateur | Duckmill Lane MK42 0AF Bedford 23 Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | South African | 161860310001 | |||||
| FOSTER, Michael Raymond | Administrateur | 4 Church Close Westoning MK45 5DH Bedford | England | British | 53280440001 | |||||
| FOX, Ian John | Administrateur | 312 Dukes Mews Muswell Hill N10 2QP London | British | 49065170003 | ||||||
| GILLIS, Neil Duncan | Administrateur | Lodge Farm High Street, Thelnetham IP22 1JL Diss Norfolk | England | British | 69204500003 | |||||
| GUYER, Paul John | Administrateur | Oakwood House 29 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | British | 100971720002 | ||||||
| HALL, Andrew James | Administrateur | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||
| HENCHOZ, Patrick | Administrateur | Huntington Court Huntington Lane HR4 7RA Hereford Herefordshire | United Kingdom | Swiss | 93431850001 | |||||
| JOHNSON, Mark Christopher | Administrateur | Little Stream Sunning Hill Road SL5 9JZ Ascot Berkshire | England | British | 48443030001 | |||||
| KELLY, Maurice William | Administrateur | Spinney Cottage Wing Road Mentmore LU7 0QG Leighton Buzzard Buckinghamshire | British | 89366130001 | ||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Administrateur | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | England | British | 135618280002 | |||||
| MCCOLLUM, Kevin Boyd | Administrateur | Waterton Stables Ampney Crucis GL7 5RX Cirencester Gloucestershire | England | British | 121972580001 | |||||
| MCGUIGAN, Marc Edward | Administrateur | Avadi Chapel Lane GL20 7ER Tewkesbury Gloucester | England | British | 93677590002 |
RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Créé le 18 juin 2009 Livré le 26 juin 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
RIVERSIDE CHILDCARE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0