AMCOL PACKAGING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMCOL PACKAGING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03210908
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMCOL PACKAGING LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe AMCOL PACKAGING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Amcol Minerals Europe Ltd
    Weaver Valley Road
    CW7 3BU Wharton Winsford
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMCOL PACKAGING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SILGEL PACKAGING LIMITED12 juin 199612 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de AMCOL PACKAGING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour AMCOL PACKAGING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 août 2010

    État du capital au 25 août 2010

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    Certificat de changement de nom

    Company name changed silgel packaging LIMITED\certificate issued on 02/05/07
    2 pagesCERTNM

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    14 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    13 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    13 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de AMCOL PACKAGING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHAYTOR, Jonathan
    The Old Vicarage Lord Sefton Way
    Great Altcar Formby
    L37 5AA Liverpool
    Secrétaire
    The Old Vicarage Lord Sefton Way
    Great Altcar Formby
    L37 5AA Liverpool
    British2764630005
    CASTAGNA, Gary
    198 Sunnybrook Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    Administrateur
    198 Sunnybrook Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    United StatesAmerican82233820001
    MEALOR, Phillip Graeme
    Brookhurst Road
    Bromborough
    CH63 0ES Wirral
    98
    Administrateur
    Brookhurst Road
    Bromborough
    CH63 0ES Wirral
    98
    United KingdomBritish130137490001
    WASHOW, Lawrence
    357 Old Sutton Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    Administrateur
    357 Old Sutton Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    UsaAmerican55047940003
    FINLAY, Shannon Lesley
    Sherrif Hales Lodge
    Sherrif Hales
    Telford
    Secrétaire
    Sherrif Hales Lodge
    Sherrif Hales
    Telford
    British48214660002
    MACKNESS, Donald Richard
    90 High Street
    Great Broughton
    TS9 7HA Middlesbrough
    Cleveland
    Secrétaire
    90 High Street
    Great Broughton
    TS9 7HA Middlesbrough
    Cleveland
    British6546440001
    NIBLETT, Elaine Patricia
    2 Harebell Glade
    Randlay
    TF3 2AX Telford
    Salop
    Secrétaire
    2 Harebell Glade
    Randlay
    TF3 2AX Telford
    Salop
    British48646930001
    SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Secrétaire désigné
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003990001
    FINLAY, Donald Joseph
    Sherrif Hales Lodge
    Sherrif Hales
    Telford
    Administrateur
    Sherrif Hales Lodge
    Sherrif Hales
    Telford
    British48214730002
    FINLAY, Shannon Lesley
    Sherrif Hales Lodge
    Sherrif Hales
    Telford
    Administrateur
    Sherrif Hales Lodge
    Sherrif Hales
    Telford
    British48214660002
    KITCHING, Peter Jeffrey
    3 Pintail Place
    Swanlow Park
    CW7 1LE Winsford
    Cheshire
    Administrateur
    3 Pintail Place
    Swanlow Park
    CW7 1LE Winsford
    Cheshire
    EnglandBritish19080360001
    NIBLETT, Elaine Patricia
    2 Harebell Glade
    Randlay
    TF3 2AX Telford
    Salop
    Administrateur
    2 Harebell Glade
    Randlay
    TF3 2AX Telford
    Salop
    British48646930001
    NIBLETT, Stanley Reginald Cyril
    2 Harebell Glade
    Randlay
    TF3 2AX Telford
    Salop
    Administrateur
    2 Harebell Glade
    Randlay
    TF3 2AX Telford
    Salop
    British48159860001
    QUEEN, Roger Charles
    Moorcote Farm
    Ellingstring
    HG4 4PL Masham
    North Yorkshire
    Administrateur
    Moorcote Farm
    Ellingstring
    HG4 4PL Masham
    North Yorkshire
    British78822570001
    SMITH, David Michael
    171 Gardner Road
    L37 8DG Formby
    Merseyside
    Administrateur
    171 Gardner Road
    L37 8DG Formby
    Merseyside
    British121687370001
    WADDICOR, John Ian, Dr
    Foxwist Green
    CW8 2BJ Whitegate
    Foxes Green Cottage
    Cheshire
    Administrateur
    Foxwist Green
    CW8 2BJ Whitegate
    Foxes Green Cottage
    Cheshire
    EnglandBritish128974600001
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Administrateur désigné
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    AMCOL PACKAGING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 août 2001
    Livré le 17 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 janv. 1998
    Livré le 17 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 juin 1996
    Livré le 11 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0