BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED

BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03211797
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED ?

    • Radiodiffusion (60100) / Information et communication

    Où se situe BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11 Old Steine
    Brighton
    BN1 1EJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2012

    État du capital au 28 juin 2012

    • Capital: GBP 266,622
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2006

    3 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2005

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2004

    5 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2003

    16 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NATHAN, Daniel Alexander Julian
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    Secrétaire
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    British75162990004
    BRATHWAITE, James Everett
    Church Farm House
    Rectory Lane
    BN16 4JU Angmering
    West Sussex
    Administrateur
    Church Farm House
    Rectory Lane
    BN16 4JU Angmering
    West Sussex
    EnglandBritish203668080001
    NATHAN, Daniel Alexander Julian
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    Administrateur
    10 Old Steine
    BN1 1EJ Brighton
    EnglandBritish75162990004
    STARK, Steven
    2 Salem Cottage The Street
    TN22 5NL Framfield
    East Sussex
    Administrateur
    2 Salem Cottage The Street
    TN22 5NL Framfield
    East Sussex
    EnglandBritish73968890003
    FRANCIS, Sharon Lesley
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    Secrétaire
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    British72419260001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    PERERA, Brandon Jayalath
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    British54457210001
    PERERA, Eugene Indrajit
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    Secrétaire
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    British56569640002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    AUBREY FLETCHER, Henry Egerton, Sir
    Town Hill Farm Dorton Road
    Chilton
    HP18 9NA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Town Hill Farm Dorton Road
    Chilton
    HP18 9NA Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish22980850001
    AXTON, Ian James
    29 Andrews Way
    SP2 8QR Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    29 Andrews Way
    SP2 8QR Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish52042080001
    CARNEGY, Christopher Roy
    29 Hulse Road
    SP1 3LU Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    29 Hulse Road
    SP1 3LU Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish5024600002
    DRUMMOND, Gordon
    7 Blunden Drive
    Cuckfield
    RH17 5HU Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    7 Blunden Drive
    Cuckfield
    RH17 5HU Haywards Heath
    West Sussex
    British34139600003
    FANSHAWE, Simon Hew Dalrymple
    10 Keslake House
    14 Chichester Terrace
    BN2 1FG Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    10 Keslake House
    14 Chichester Terrace
    BN2 1FG Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish50512000001
    FLANAGAN, Mark Simon
    14 Denehurst Gardens
    W3 9QY London
    Administrateur
    14 Denehurst Gardens
    W3 9QY London
    British69776160004
    FRANCIS, Sharon Lesley
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    Administrateur
    3 Primrose Close
    DL16 7YE Spennymoor
    County Durham
    British72419260001
    HALLETT, Lawrence Albert, Dr
    565 Earlham Road
    NR4 7TF Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    565 Earlham Road
    NR4 7TF Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish12078930003
    HARBER, David
    Flat 3, 22 Salisbury Road
    BN3 3AE Hove
    Administrateur
    Flat 3, 22 Salisbury Road
    BN3 3AE Hove
    British96014070001
    JOSEPHS, John Irving
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    22 Osbaldeston Gardens
    NE3 4JE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish3830990001
    KNIGHT, William Roger
    10 Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    10 Liverpool Road
    KT2 7SZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish26945620001
    LAWRENCE, Eric Alexander
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    26 Foxhills Covert
    Whickham
    NE16 5TN Newcastle Upon Tyne
    British4250810002
    NATHAN, Daniel Alexander Julian
    6b Steine Gardens
    BN2 1WB Brighton
    Administrateur
    6b Steine Gardens
    BN2 1WB Brighton
    British75162990002
    NICE, Timothy Christopher
    Rebels Roost
    Finches Lane, Twyford
    SO21 1QF Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Rebels Roost
    Finches Lane, Twyford
    SO21 1QF Winchester
    Hampshire
    British66693480002
    PERERA, Brandon Jayalath
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Barham
    Courtmead Road
    RH17 5LP Cuckfield
    Haywards Heath
    West Sussex
    British54457210001
    PERERA, Eugene Indrajit
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    42 Devonshire Place
    BN2 1QB Brighton
    East Sussex
    British56569640002
    RADFORD KIRBY, Simon Gerard
    66 Greenways
    Ovingdean
    BN2 7BL Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    66 Greenways
    Ovingdean
    BN2 7BL Brighton
    East Sussex
    British50035890001
    SHAW, Barry
    18 Ayzgarth Rise
    YO16 7HX Bridlington
    East Yorkshire
    Administrateur
    18 Ayzgarth Rise
    YO16 7HX Bridlington
    East Yorkshire
    British96413730001
    SMITH, William Alexander
    19 Arundel Street
    BN2 5TG Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    19 Arundel Street
    BN2 5TG Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish48903440001
    SORBY-FIRTH, Erika
    45 Stanley Road
    SG2 0EE Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    45 Stanley Road
    SG2 0EE Stevenage
    Hertfordshire
    British59119380001
    STARK, Steven
    F15/50 Rochester Gardens
    BN3 3HT Hove
    East Sussex
    Administrateur
    F15/50 Rochester Gardens
    BN3 3HT Hove
    East Sussex
    British73968890001
    WEBB, Martin Jonathan
    15 Montpelier Villas
    BN1 3DG Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    15 Montpelier Villas
    BN1 3DG Brighton
    East Sussex
    British55939610002
    WINGATE, Guy David Alexander
    Basement Flat 7 Pilgrims Lane
    NW3 1SJ London
    Administrateur
    Basement Flat 7 Pilgrims Lane
    NW3 1SJ London
    British17365640001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    BRIGHTON & HOVE LOCAL RADIO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 oct. 2002
    Livré le 22 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • John Mark
    Transactions
    • 22 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2002
    Livré le 02 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures and fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • John Mark
    Transactions
    • 02 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2001
    Livré le 24 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 oct. 1998
    Livré le 14 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Wayleave agreement
    Créé le 26 févr. 1998
    Livré le 04 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    £5,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Deposit account of £5,000.
    Personnes ayant droit
    • Sussex Heights (Brighton) Limited
    Transactions
    • 04 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0