BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED

BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03213650
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MILL HILL SOCCER CENTRE LIMITED 05 sept. 199605 sept. 1996
    POWERLEAGUE HENDON LTD07 août 199607 août 1996
    CROWNCREST LEISURE LIMITED18 juin 199618 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juil. 2010

    État du capital au 08 juil. 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sean Tracey le 18 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Sheena Marion Beckwith le 18 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Sheena Marion Beckwith le 18 juin 2010

    1 pagesCH03

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    7 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 28 juin 2008

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 30 juin 2007

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 01 juil. 2006

    8 pagesAA

    legacy

    10 pages363s

    Comptes annuels établis au 02 juil. 2005

    14 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Certificat de réduction du capital émis

    1 pagesCERT15

    legacy

    5 pagesOC138

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BECKWITH, Sheena Marion
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Secrétaire
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    British77381700002
    BECKWITH, Sheena Marion
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Administrateur
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    ScotlandBritish77381700002
    TRACEY, Sean Paul
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    Administrateur
    Powerleague Soccer Centre
    Pursley Road
    NW7 2BB Millhill
    London
    ScotlandBritish105080540001
    HALL, Jeremy Clive
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    British35444860001
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Secrétaire désigné
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001
    BUCHANAN, William Arthur Neil
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish67066450003
    HALL, Jeremy Clive
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    42 Newacres
    Newburgh
    WN8 7TU Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish35444860001
    MOORE, Adrian Richard
    1 Chaucer Close
    SL4 3ER Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    1 Chaucer Close
    SL4 3ER Windsor
    Berkshire
    UkBritish96121170001
    ORMEROD, Warren David
    34 Old Oak Close
    WS9 8SE Aldridge
    West Midlands
    Administrateur
    34 Old Oak Close
    WS9 8SE Aldridge
    West Midlands
    British49052640001
    SELLERS, Philip Edward
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Yarrimba 31 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10598350001
    TAYLOR, Alan Lewis
    6 Heathside Close
    Moor Park
    HA6 2EQ Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    6 Heathside Close
    Moor Park
    HA6 2EQ Northwood
    Middlesex
    British4947700001
    FIRST DIRECTORS LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Administrateur désigné
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000770001

    BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 déc. 1999
    Livré le 16 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as trustee on behalf of the investors (as defined) under the investment agreement of even date pursuant to the deed of guarantee of even date
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 déc. 1999
    Livré le 11 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 août 1999
    Livré le 12 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 avr. 1998
    Livré le 02 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Excluding the legally charged property and including stocks and shares acquired pursuant to scrip dividends and other than royalties and other sums payable in respect of all intellectual property rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 02 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 avr. 1998
    Livré le 02 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H land at pursley road hendon london borough of barnet. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 02 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0