ELECTRONIQUE GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéELECTRONIQUE GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03214376
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O ROBNOR RESINS LIMITED
    31 Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAVENGOLD LIMITED19 juin 199619 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Robnor Resins Limited Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE à C/O C/O Robnor Resins Limited 31 Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE le 21 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2014

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Crawford Wilson Gillan en tant que directeur le 16 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Crawford Wilson Gillan en tant que secrétaire le 16 févr. 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 janv. 2015

    État du capital au 19 janv. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 janv. 2014

    État du capital au 17 janv. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Frederick Hawley en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Crawford Wilson Gillan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Crawford Wilson Gillan en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mr John Rae Henderson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Frederick Hawley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gilles Coulombeau en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    pagesANNOTATION

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gilles Maire Jean Francois Coulombeau le 01 mars 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    11 pagesAA

    État du capital au 28 juil. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de ELECTRONIQUE GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENDERSON, John Rae
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    Administrateur
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    ScotlandBritishDirector43301650001
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    Secrétaire
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    182622810001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director13540840002
    HARPER CORPORATION LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Secrétaire désigné
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013980001
    COULOMBEAU, Gilles Maire Jean Francois
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomFrenchCompany Director15117870004
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    Administrateur
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    United KingdomBritishDirector182618510001
    HARDIE, Reginald George
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    BritishDirector422650001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director13540840002
    LING, Philip Henry
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector2326420001
    WALTON, Michael Edward D'Arcy
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    Administrateur
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    EnglandBritishCompany Director34866270001
    L.C.I. DIRECTORS LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Administrateur désigné
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013970001

    ELECTRONIQUE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 1999
    Livré le 21 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    65,002 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of electronique limited and all stocks securities and other property charged under the terms of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 15 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a units 2A and 2B hulme hall lane manchester t/n GM413956. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 15 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a unit b harwood road littlehampton t/n WSX54330. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 15 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a unit a harwood road littlehampton t/n WSX50703. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 15 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a land on the west side of byrom street liverpool t/n MS125497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 15 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a unit 2 harwood road littlehampton t/n WSX79974. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 15 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 42-48 fentenoy street liverpool t/n MS124039. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 févr. 1999
    Livré le 23 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For property details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of keyman policy
    Créé le 10 mars 1997
    Livré le 19 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The life assurance policy dated 16 february 1996 issuedby crowe life on tthe life of colin douglas murray for the amount of £100,000 contract no. 733/Rml 16762 certificate number sed 1289 and all sums assured thereby and bonuses and benefits arising thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman policy
    Créé le 04 déc. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brèves mentions
    Crowe life assurance company policy no.sed 1221 dated 13.9.96 over the life of christopher james wilkins, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman policy
    Créé le 04 déc. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brèves mentions
    Crowe life assurance company policy no.sed 1217 dated 13.9.96 over the life of david smith, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman policy
    Créé le 04 déc. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brèves mentions
    Crowe life assurance company policy no.sed 1219 dated 13.9.96 over the life of giles marie coulombeau, sum assured:£500,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman policy
    Créé le 04 déc. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brèves mentions
    Crowe life assurance company policy no.sed 1218 dated 13.9.96 over the life of neil ancell, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman policy
    Créé le 04 déc. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Brèves mentions
    Crowe life assurance company policy no.sed 1220 dated 13.9.96 over the life of fredrick william hawley, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage and charge
    Créé le 31 juil. 1996
    Livré le 02 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lands and premises situate in the townland of killyhevlin parish of enniskillen barony of tirkennedy and county fermanagh .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 juil. 1996
    Livré le 02 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0