BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03214421
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRUNTWOOD SECOND PROPERTIES LIMITED12 août 199612 août 1996
    BRUNTWOOD SECOND ESTATES LIMITED19 juil. 199619 juil. 1996
    SLATERSHELFCO 318 LIMITED20 juin 199620 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT à C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB le 07 juin 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 avr. 2016

    État du capital au 12 avr. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 avr. 2015

    État du capital au 09 avr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2014

    État du capital au 08 avr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin James Crotty le 28 juin 2013

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Mr Kevin James Crotty en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Andrew Allan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* le 05 janv. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Robert Yates en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Marland en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Malin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Iain Grant en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Crowther en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Secrétaire
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    British96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritish117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Secrétaire
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Secrétaire désigné
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish80043450001
    CROWTHER, Peter Andrew
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish102710080002
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Administrateur
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritish2582690002
    GUEST, David Robert James
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish102710440001
    HEWITT, Michael
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish108552010001
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish48153170001
    MARLAND, John Roderick
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish102712120001
    MORRIS, Antony Howard
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    Administrateur
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    British48178610001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Administrateur désigné
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ROBERTS, Christopher Andrew
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139641910001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish30535590006

    BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    B2000 borrower security agreement
    Créé le 06 févr. 2007
    Livré le 20 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Transactions
    • 20 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 2004
    Livré le 01 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a overseas house, quay street t/no LA355462 together with all buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon, all plant, machinery, implements, utensils, building materials, carpets, furniture andequipment now or in the future placed on or used in or about the mortgaged prope. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Trustee for the Banks)
    Transactions
    • 01 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 déc. 2003
    Livré le 03 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the freehold property known as overseas house quay street t/n LA355462 by way of fixed charge all plant machinery implements building materials all of the companys rights and benefits under any agreements and the benefit of each and all of the personal covenants by the lesses underlesses or licensees under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 nov. 2000
    Livré le 24 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining marsland house,marsland rd,sale,gt.manchester.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 1999
    Livré le 30 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a lancastrian office buildings talbot road stretford greater manchester t/n-LA234523.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 27 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and and buildings k/a bank house faulkner street manchester t/no.LA360892. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 27 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the l/h land and buildings k/a bank chambers adjoining bank house faulkner street manchester being the whole of the land under t/nos.GM789357 and GM789673. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 juin 1998
    Livré le 15 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a marsland house marsland road sale t/nos.GM53071 and GM323015 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1996
    Livré le 03 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a quay house 28 quay street manchester t/n GM66438 the goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 1996
    Livré le 19 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0