ONEADVANCED LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ONEADVANCED LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03214465 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ONEADVANCED LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ONEADVANCED LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 28 févr. 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 nov. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ONEADVANCED LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 05 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ONEADVANCED LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 23 févr. 2026
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 30 pages | MA | ||||||||||
Inscription de la charge 032144650018, créée le 01 déc. 2025 | 40 pages | MR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2025 | 49 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 032144650017 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 032144650016 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Inscription de la charge 032144650017, créée le 17 juin 2025 | 41 pages | MR01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed advanced business software and solutions LIMITED\certificate issued on 01/05/25 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2024 | 48 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2023 | 39 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gordon James Wilson en tant que directeur le 05 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon David Walsh en tant qu'administrateur le 09 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Eric Dews en tant qu'administrateur le 09 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2022 | 38 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard James Kerr en tant que directeur le 10 févr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 01 févr. 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Modification des détails de Redac Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 juil. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ditton Park Riding Court Road Datchet Berkshire SL3 9LL United Kingdom à The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street Birmingham B1 1RF le 15 juil. 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ONEADVANCED LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPELL, Jayne Louise | Secrétaire | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox Level 3 United Kingdom | 295530320001 | |||||||
| DEWS, Stephen Eric | Administrateur | The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham Advanced Computer Software Group Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 310006210001 | |||||
| WALSH, Simon David | Administrateur | The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham Advanced Computer Software Group Limited United Kingdom | England | British | 298153810001 | |||||
| BAILLIE CARRIGAN, Adrienne Anne | Secrétaire | 6 Heather Grove Hartley Wintney RG27 8SE Hook Hampshire | British | 84231690002 | ||||||
| BRANIFF, Edward | Secrétaire | 19 Red Oak Lane FOREIGN Kinnelon New Jersey 07405 Usa | Us | 80613310001 | ||||||
| ELLIS, Christopher John Milton | Secrétaire | Bevisbury House Church Lane Easton SO21 1EH Winchester | British | 37787230001 | ||||||
| GIBSON, Paul David | Secrétaire | 163 Valley Road WD3 4BR Rickmansworth Hertfordshire | British | 192439290001 | ||||||
| HOSIE, Michael Douglas | Secrétaire | Woodbine Cottage The Long Road GU10 4DL Rowledge Surrey | British | 23706640001 | ||||||
| LOWE, Hilary Anne | Secrétaire | Portsmouth Road KT11 3HQ Cobham Munro House Surrey England | 159147910001 | |||||||
| SHAW, Natalie Amanda | Secrétaire | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox United Kingdom | 251006100001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BOLIN, Bret Richard, Mr. | Administrateur | Riding Court Road SL3 9LL Datchet Ditton Park Berkshire United Kingdom | United States | American | 198635550001 | |||||
| BOLLAND, Martin Keith | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 | England | British | 142514470001 | |||||
| BRANIFF, Edward | Administrateur | 19 Red Oak Lane FOREIGN Kinnelon New Jersey 07405 Usa | Us | 80613310001 | ||||||
| CATER, Eric John | Administrateur | Common Lane The Ridge Little Baddow CM3 4RY Chelmsford Five Oaks Essex | United Kingdom | British | 79393220001 | |||||
| CONWAY, Christopher John | Administrateur | Pensford Avenue Kew TW9 4HP Richmond 32 Surrey | United Kingdom | Irish | 69898690001 | |||||
| ELLIS, Christopher John Milton | Administrateur | Bevisbury House Church Lane Easton SO21 1EH Winchester | United Kingdom | British | 37787230001 | |||||
| FATTAL, Leon | Administrateur | 25 Calonne Road SW19 5HH London | England | Canadian | 66516830001 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| HARRISON, Michael Geoffrey | Administrateur | Clive House Portsmouth Road KT10 9LH Esher Surrey | Great Britain | British | 42238790001 | |||||
| HICKS, Andrew William | Administrateur | Riding Court Road SL3 9LL Datchet Ditton Park Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 309297040001 | |||||
| HOSIE, Michael Douglas | Administrateur | Woodbine Cottage The Long Road GU10 4DL Rowledge Surrey | England | British | 23706640001 | |||||
| KERR, Richard James | Administrateur | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox Level 3 United Kingdom | England | British | 118897360002 | |||||
| MENASCHE, Harry Jeffrey | Administrateur | 22 Stanford Court Cornwall Gardens SW7 4AB London | British | 10423150002 | ||||||
| MILLWARD, Guy Leighton | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 203759730001 | |||||
| MILLWARD, Guy Leighton | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 203759730001 | |||||
| MOULTON, Jonathan Paul | Administrateur | Sequoia 57 Kippington Road TN13 2LL Sevenoaks Kent | British | 14450900001 | ||||||
| MURRIA, Vinodka | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | England | British | 57998050007 | |||||
| THOMPSON, Mark Harry | Administrateur | The Bungalow Forest Crescent KT21 1JU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 156095450001 | |||||
| TIMOTHY, Fiona Maria | Administrateur | Holly Cottage Kings Lane SL6 9AY Cookham Dean Berkshire | England | British | 161343370001 | |||||
| WALLIS, Graham Charles | Administrateur | 15 St Thomas Street BA5 2UU Wells Somerset | British | 45391250001 | ||||||
| WILSON, Gordon James | Administrateur | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox Level 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 200853210001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ONEADVANCED LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redac Limited | 06 avr. 2016 | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox Level 3 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0