OVERSON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOVERSON LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03214899
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OVERSON LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe OVERSON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Recovery Hjs
    12 -14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OVERSON LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2007
    Date d'échéance des prochains comptes30 avr. 2008
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2006

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour OVERSON LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au21 juin 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation05 juil. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour OVERSON LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour OVERSON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Charles Henry Pfister en tant que secrétaire le 07 mai 2015

    2 pagesTM02

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    5 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    6 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    10 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages288b

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2006

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2005

    7 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages403a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2004

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return29 juin 2004

    legacy

    363(287)
    annual-return29 juin 2004

    legacy

    363(288)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2003

    7 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2002

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    legacy

    3 pages395

    legacy

    3 pages395

    Qui sont les dirigeants de OVERSON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    Secrétaire
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire désigné
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    PFISTER, Charles Henry
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    British67081640001
    BURGON, Mark Edward
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    Administrateur
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritish100433200001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Administrateur désigné
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    OVERSON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 19 août 2002
    Livré le 30 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land forming part of the garden of the property known as outerfield,tilford road,hindhead; part t/no sy 108357. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 2002
    Livré le 24 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £60,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that freehold land formerly part of the property outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Personnes ayant droit
    • Mirafora Themistocli
    Transactions
    • 24 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 2002
    Livré le 24 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £75,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Personnes ayant droit
    • Carolyn Mary Popham
    Transactions
    • 24 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 2002
    Livré le 24 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £25,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Personnes ayant droit
    • Montagu Graeme Macdonald
    Transactions
    • 24 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 2002
    Livré le 05 févr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a land adjoining courts mount road haslemere surrey.
    Personnes ayant droit
    • C.H. Pfister & R.J. Hager as Trustees of D M Hager Discretionary Settlement
    Transactions
    • 05 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 2002
    Livré le 05 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land adjoining courts mount barn courts mount road haslemere surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 15 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Personnes ayant droit
    • R J Hager(As Trustees of the Mrs D M Hager 1997 Settlement)
    • C H Pfister
    Transactions
    • 15 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 11 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Robert Michael Macdonald
    • Montagu Graeme Macdonald
    • Carolyn Mary Popham
    Transactions
    • 11 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 11 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Donald Slough
    Transactions
    • 11 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 28 juil. 2000
    Livré le 01 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H part of the old bus depot midhurst west sussex. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of whole
    Créé le 19 nov. 1999
    Livré le 19 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £25,000 due from the company to the chargee in accordance with the terms of the supplemental agreement of even date
    Brèves mentions
    F/Hold land lying to the north east of petworth rd,haslemere and garages; t/no sy 677075.
    Personnes ayant droit
    • Carolyn Mary Popham
    Transactions
    • 19 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of whole
    Créé le 03 juin 1998
    Livré le 09 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000 due or to become due from the company to the chargees
    Brèves mentions
    Land to the north of petworth road haslemere and garages surrey.
    Personnes ayant droit
    • Carolyn Mary Popham and Robert Michael Macdonald
    Transactions
    • 09 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 03 juin 1998
    Livré le 05 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the rear of 24 petworth road haslemere surrey t/n SY677075. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of whole
    Créé le 19 nov. 1997
    Livré le 21 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargees
    Brèves mentions
    Land and buildings adjacent to greencroft scotland drive haslemere surreyt/no.SY248372.
    Personnes ayant droit
    • Carolyn Mary Popham
    • Robert Michael Macdonald
    Transactions
    • 21 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed floating charge
    Créé le 13 oct. 1997
    Livré le 14 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 18TH august 1997
    Brèves mentions
    The f/h property k/a the wheatsheaf grayswood roaf witley haslemere surrey t/n SY382663 and by way of floating charge the undertaking of the company and all it's property assets and rights present and future.
    Personnes ayant droit
    • Plt Limited
    Transactions
    • 14 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 21 mai 1997
    Livré le 22 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjacent to greencroft scotland drive haslemere surrey t/n-SY248372 by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 juil. 1996
    Livré le 07 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 8TH july 1996 and this charge
    Brèves mentions
    First fixed legal mortgage f/h property k/a the cottages verdley place furnhurst chichester west sussex first fixed charge all the company's right title and interest in any account from time to time opened and maintained by the company in accordance with the provisions of this charge and all monies (including interest thereon) standing from time to time to the credit of such account. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Plt Limited
    Transactions
    • 07 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 05 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of whole
    Créé le 31 juil. 1996
    Livré le 01 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £140,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    C1-C8 and GC1-GC5 verdley place fernhurst t/no wsx 195964.
    Personnes ayant droit
    • Mrs Dulcie Marguerite Hager
    Transactions
    • 01 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 05 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OVERSON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 févr. 2007Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Shane Biddlecombe
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    practitioner
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Gordon John Johnston
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    practitioner
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0