CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED

CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03215059
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Greenfield Business Park No2
    Greenfield
    CH8 7GJ Holywell Flintshire
    North Wales
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CENTURY HOMES TIMBER FRAMES LIMITED27 févr. 200327 févr. 2003
    ALPHA TIMBER FRAME LIMITED21 juin 199621 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2012

    État du capital au 03 déc. 2012

    • Capital: GBP 118,750
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dermot Mulvihill en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Geoff Doherty en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Mcdonald en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Gilbert Mccarthy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brendan Feeney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Dermot Mulvihill en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KINGSPAN GROUP LIMITED
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    Secrétaire
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    107980110001
    DOHERTY, Geoff Patrick
    Somerton
    Castleknock Golf Club, Porterstown Road
    Castleknock
    11
    Dublin 15
    Ireland
    Administrateur
    Somerton
    Castleknock Golf Club, Porterstown Road
    Castleknock
    11
    Dublin 15
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director161069960001
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    Secrétaire
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    BritishChartered Accountant Company D68232410001
    HALEY, Robert George
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    Secrétaire
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    BritishCompany Director49852280001
    KNIGHT, Amanda Jayne
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    Secrétaire
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    British78119010001
    MCBRIDE, James William
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    Secrétaire
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    IrishTechnical Director84570680001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Secrétaire
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrishDirector145024250001
    PATTERSON, Margaret
    5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Secrétaire
    5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    British64805740001
    ROWLES, Paul
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    Secrétaire
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    British47041550002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FEENEY, Brendan
    86 The Grove
    Celbridge
    Kildare
    Ireland
    Administrateur
    86 The Grove
    Celbridge
    Kildare
    Ireland
    IrelandIrishDirector197044280001
    FIGUEIRA, John Andrew
    Lutetia
    18 Friard Gate
    GU2 7PQ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Lutetia
    18 Friard Gate
    GU2 7PQ Guildford
    Surrey
    EnglandBritishTechnical Director127913060002
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    Administrateur
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    BritishChartered Accountant68232410001
    GREENSTREET, Simon David John
    Polly Cottage
    Southover Way Hunston
    PO20 6NY Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Polly Cottage
    Southover Way Hunston
    PO20 6NY Chichester
    West Sussex
    BritishCompany Director47041540001
    HALEY, Robert George
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    Administrateur
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    BritishCompany Director49852280001
    KNIGHT, Colwyn Roy
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    Administrateur
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    WalesBritishCompany Director23297760001
    KNIGHT, Melville William
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Administrateur
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    WalesBritishCompany Director23297750005
    MCBRIDE, James William
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    Administrateur
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    IrishTechnical Director84570680001
    MCCARTHY, Gilbert
    Forest Haven
    Cabra
    IRISH Kingscourt
    Co Cavan
    Ireland
    Administrateur
    Forest Haven
    Cabra
    IRISH Kingscourt
    Co Cavan
    Ireland
    IrelandIrishDirector172436310001
    MCCAUGHEY, Gerald Vincent
    Lathlurcan
    IRISH Co. Monaghan
    Ireland
    Administrateur
    Lathlurcan
    IRISH Co. Monaghan
    Ireland
    IrishManaging Director84914210002
    MCDONALD, Paul
    17 Cairnsfort
    Stepaside
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    17 Cairnsfort
    Stepaside
    Dublin 18
    Ireland
    IrishMarketing Director84570330002
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Cloverhill
    Co Meath
    Ireland
    Administrateur
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Cloverhill
    Co Meath
    Ireland
    IrelandIrishDirector145024250001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Administrateur
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrelandIrishDirector145024250001
    MURTAGH, Brendan
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Administrateur
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector30924190002
    MURTAGH, Eugene
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishDirector16536550001
    MURTAGH, Gene
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    Administrateur
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    IrelandIrishDirector66920570002
    PATTERSON, Gordon
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Administrateur
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern IrelandBritishCompany Director65359330001
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Administrateur
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishCompany Director65359270002
    WHITTLE, Nicholas
    Leander Avenue Road
    GU6 7LL Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Leander Avenue Road
    GU6 7LL Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director49770220002

    CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 09 sept. 2005
    Livré le 16 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    £8255 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    £8255.
    Personnes ayant droit
    • Mary Louise Seldon
    Transactions
    • 16 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 19 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 14 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 30 tafarnaubach industrial estate tredegar monmouthshire WA799148. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 07 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 29 tafarnaubach industrial estate tredgar monmouthshire t/no: WA829943. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 30 juil. 1999
    Livré le 19 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 29 tafarnaubach industrial estate tredegar.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 juin 1999
    Livré le 02 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent security deposit deed
    Créé le 21 avr. 1997
    Livré le 26 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease
    Brèves mentions
    The deposit of £8,255.
    Personnes ayant droit
    • Mary Louise Foulston
    Transactions
    • 26 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 26 juil. 1996
    Livré le 13 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 30 tafarnaubach industrial estate tredegar benefit of all rights licences contracts deeds assigns goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 25 juil. 1996
    Livré le 27 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 27 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0