AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03215277 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | First Floor Kirkdale House Kirkdale Road E11 1HP Leytonstone London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 16 juin 2015
| 7 pages | SH06 | ||||||||||||||
Rachat d'actions propres. | 3 pages | SH03 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 01 juin 2015
| 8 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Simon Christoffer Stedman en tant que secrétaire le 06 mars 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Enamur Rahman en tant que secrétaire le 06 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Simon Christoffer Stedman en tant qu'administrateur le 24 févr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Henry Thomas Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de James Keeble en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Julie Buck le 20 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Enamur Rahman le 31 oct. 2013 | 2 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Enamur Rahman le 31 oct. 2013 | 2 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Enamur Rahman le 31 oct. 2013 | 2 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Trevor Keeble le 31 oct. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Trevor Keeble le 15 nov. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Copper House Snakes Lane East Woodford Green Essex IG8 7HX United Kingdom* le 04 nov. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEDMAN, Simon Christoffer | Secrétaire | Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st Floor United Kingdom | 196345130001 | |||||||
BUCK, Julie | Administrateur | Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Land Director | 139876740001 | ||||
SMITH, Henry Thomas | Administrateur | Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 155055100001 | ||||
STEDMAN, Simon Christoffer | Administrateur | Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 190800880001 | ||||
BURTON, Colin | Secrétaire | 14 Barnsley Road RM3 9LP Romford Essex | British | 86084200001 | ||||||
DANIELS, James | Secrétaire | 21 Byron Avenue South Woodford E18 2HH London | British | Accountant | 110484910001 | |||||
MAHONEY, Roger | Secrétaire | Decaris Lodge Farm End Sewardstonebury E4 7QS London | British | Director | 48326520001 | |||||
RAHMAN, Enamur | Secrétaire | Floor Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st United Kingdom | 152401680001 | |||||||
ROSE, Paul Clifford | Secrétaire | Mansfield Hill Chingford E4 7JU London 8 | British | 52815670001 | ||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
KEEBLE, James Trevor | Administrateur | Floor Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone E11 1HP London 1st United Kingdom | England | British | Financial Adviser | 127852330005 | ||||
ROSE, Paul Clifford | Administrateur | Mansfield Hill Chingford E4 7JU London 8 | United Kingdom | British | Technical Manager | 52815670001 | ||||
SMITH, Henry Thomas | Administrateur | Great Oaks Bury Road Sewardstonebury E4 7QL London | United Kingdom | British | Manager | 142764470001 | ||||
STEDMAN, Simon Christoffer | Administrateur | 136 Glengall Road IG8 0DS Woodford Green Essex | United Kingdom | British | Accountant | 190800880001 | ||||
COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 08 janv. 2007 Livré le 23 janv. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 03 oct. 2006 Livré le 13 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit initially of £1,000,000 credited to account designation number 42081513 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 août 2003 Livré le 23 août 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The langdon park community centre t/n EGL452009 and NGL391621. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of agreement for the purchase of property | Créé le 12 août 2003 Livré le 23 août 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The langdon park community centre t/n egl 452009 and ngl 391621 together with the agreement dated 19 july 2002 (as defined therein). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 29 août 2002 Livré le 13 sept. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit initially of £485,500 credited to account designation 48120251 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over securities | Créé le 08 nov. 1999 Livré le 11 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 2 ordinary shares of £1 each in aitch archway limited and in greenman properties limited and any further securities together with all dividends interest or other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 oct. 1999 Livré le 14 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Memorandum of deposit and charge | Créé le 02 juil. 1998 Livré le 15 juil. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All stocks shares marketable and other securities of whatsoever nature now held by the bank on the company's behalf or held to the order of the bank or transferred to it or its nominees or registered in its or their names by or for the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0