AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED

AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAITCH GROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03215277
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor Kirkdale House
    Kirkdale Road
    E11 1HP Leytonstone
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AITCH HOLDINGS LIMITED21 juin 199621 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Annulation d'actions. État du capital au 16 juin 2015

    • Capital: GBP 130,665.96
    7 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    3 pagesSH03

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital après une attribution d'actions au 01 juin 2015

    • Capital: GBP 218,974.68
    8 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2015

    État du capital au 06 juil. 2015

    • Capital: GBP 130,665.96
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2014

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Christoffer Stedman en tant que secrétaire le 06 mars 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Enamur Rahman en tant que secrétaire le 06 mars 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Simon Christoffer Stedman en tant qu'administrateur le 24 févr. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2014

    État du capital au 23 juin 2014

    • Capital: GBP 130,665.96
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2013

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Henry Thomas Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Keeble en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Julie Buck le 20 mars 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Enamur Rahman le 31 oct. 2013

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées du secrétaire Enamur Rahman le 31 oct. 2013

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées du secrétaire Enamur Rahman le 31 oct. 2013

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Trevor Keeble le 31 oct. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Trevor Keeble le 15 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Copper House Snakes Lane East Woodford Green Essex IG8 7HX United Kingdom* le 04 nov. 2013

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEDMAN, Simon Christoffer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    196345130001
    BUCK, Julie
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishLand Director139876740001
    SMITH, Henry Thomas
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector155055100001
    STEDMAN, Simon Christoffer
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road
    Leytonstone
    E11 1HP London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant190800880001
    BURTON, Colin
    14 Barnsley Road
    RM3 9LP Romford
    Essex
    Secrétaire
    14 Barnsley Road
    RM3 9LP Romford
    Essex
    British86084200001
    DANIELS, James
    21 Byron Avenue
    South Woodford
    E18 2HH London
    Secrétaire
    21 Byron Avenue
    South Woodford
    E18 2HH London
    BritishAccountant110484910001
    MAHONEY, Roger
    Decaris Lodge Farm End
    Sewardstonebury
    E4 7QS London
    Secrétaire
    Decaris Lodge Farm End
    Sewardstonebury
    E4 7QS London
    BritishDirector48326520001
    RAHMAN, Enamur
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    152401680001
    ROSE, Paul Clifford
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    Secrétaire
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    British52815670001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    KEEBLE, James Trevor
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Kirkdale House, 7 Kirkdale Road Leytonstone
    E11 1HP London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Adviser127852330005
    ROSE, Paul Clifford
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    Administrateur
    Mansfield Hill
    Chingford
    E4 7JU London
    8
    United KingdomBritishTechnical Manager52815670001
    SMITH, Henry Thomas
    Great Oaks
    Bury Road Sewardstonebury
    E4 7QL London
    Administrateur
    Great Oaks
    Bury Road Sewardstonebury
    E4 7QL London
    United KingdomBritishManager142764470001
    STEDMAN, Simon Christoffer
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    136 Glengall Road
    IG8 0DS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritishAccountant190800880001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    AITCH GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 janv. 2007
    Livré le 23 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Charge of deposit
    Créé le 03 oct. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of £1,000,000 credited to account designation number 42081513 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 12 août 2003
    Livré le 23 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The langdon park community centre t/n EGL452009 and NGL391621. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of agreement for the purchase of property
    Créé le 12 août 2003
    Livré le 23 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The langdon park community centre t/n egl 452009 and ngl 391621 together with the agreement dated 19 july 2002 (as defined therein). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 29 août 2002
    Livré le 13 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of £485,500 credited to account designation 48120251 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over securities
    Créé le 08 nov. 1999
    Livré le 11 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 ordinary shares of £1 each in aitch archway limited and in greenman properties limited and any further securities together with all dividends interest or other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 11 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 oct. 1999
    Livré le 14 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Créé le 02 juil. 1998
    Livré le 15 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stocks shares marketable and other securities of whatsoever nature now held by the bank on the company's behalf or held to the order of the bank or transferred to it or its nominees or registered in its or their names by or for the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 15 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0