HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED

HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03217501
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED ?

    • Autres activités auxiliaires à l'assurance et au financement de la retraite (66290) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    20 Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HARDY UNDERWRITING GROUP PLC24 juin 199624 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01
    X93NFW3N

    Notification de Cna Financial Corporation en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02
    X8YAC6FN

    Cessation de Hardy Underwriting Bermuda Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC07
    X8YAC4EH

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X8WT2XSQ

    Statuts

    21 pagesMA
    R8INBGQ8

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Shares capital reduced/the share premium account of the company reduced 06/11/2019
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    1 pagesSH20
    A8IO1MCA

    État du capital au 25 nov. 2019

    • Capital: GBP 0.4
    4 pagesSH19
    A8IO1MCQ

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    A8IO1MC2

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 12 nov. 2019

    • Capital: GBP 2,516,000.40
    4 pagesSH01
    A8IDQJVK

    legacy

    1 pagesSH20
    A8IB6ZFU

    État du capital au 19 nov. 2019

    • Capital: GBP 0.40
    5 pagesSH19
    A8IB6ZBM

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    A8IB6ZFM

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 06/11/2019
    RES13

    Nomination de Mr Phillip John Hamer en tant qu'administrateur le 26 juil. 2019

    2 pagesAP01
    X8ATP2J5

    Cessation de la nomination de David John Brosnan en tant que directeur le 29 juil. 2019

    1 pagesTM01
    X8ATP13T

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X87LCA83

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    22 pagesAA
    A85DUT3U

    État du capital après une attribution d'actions au 12 déc. 2018

    • Capital: GBP 1,000,001.80
    4 pagesSH01
    A84JBM1N

    État du capital après une attribution d'actions au 20 déc. 2018

    • Capital: GBP 1,000,001.0
    8 pagesSH01
    A7X0KNUP

    État du capital après une attribution d'actions au 20 déc. 2018

    • Capital: GBP 1,000,001
    8 pagesSH01
    A7WDJ6OH

    Cessation de la nomination de Patrick James Gage en tant que directeur le 12 déc. 2018

    1 pagesTM01
    X7KT4GVF

    Qui sont les dirigeants de HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAMER, Phillip John
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    EnglandBritishDirector244322280001
    STEVENS, David John
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer125359810003
    CAITHIE, Tara Alexandra
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    241904920001
    CRUWYS, Rhodri David
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    182180320001
    HUTCHINGS, Theresa
    The Hollies 8 Morgans Road
    SG13 8BS Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Hollies 8 Morgans Road
    SG13 8BS Hertford
    Hertfordshire
    British2561410001
    LEPAGE, Virginie
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    243097420001
    LYNN, Marjorie Eva
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    231760620001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    ABBOTT, Richard David
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    Administrateur
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    EnglandBritishCompany Director78205110001
    BROSNAN, David John
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    EnglandAmericanChief Executive185348230001
    DUNNING, David Victor
    12 Edinburgh Close
    Southwater
    RH13 9XB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    12 Edinburgh Close
    Southwater
    RH13 9XB Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishFinance Director86147200001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    BritishDirector14185110002
    GAGE, Patrick James
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 3BY London
    20
    England
    United KingdomBritishUnderwriter120046210002
    HARDY, Peter Willes
    Clumber Chase Lane
    GU27 3AG Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Clumber Chase Lane
    GU27 3AG Haslemere
    Surrey
    BritishCompany Director25482320001
    HOOK, Christian Robert Macnachtan
    Camptoun House
    EH39 5BA Drem
    East Lothan
    Administrateur
    Camptoun House
    EH39 5BA Drem
    East Lothan
    ScotlandBritishSolicitor147980980001
    IVORY, Ian Eric
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    Administrateur
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritishCompany Director69668870001
    LESLIE, Alastair Pinckard
    Seasyde House
    PH2 7TA Errol
    Perthshire
    Administrateur
    Seasyde House
    PH2 7TA Errol
    Perthshire
    BritishBusinessman6420150001
    LEWY, Richard John
    3 Maytrees
    WD7 8AW Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Maytrees
    WD7 8AW Radlett
    Hertfordshire
    BritishInvestment Consultant63043220001
    LLOYD, Peter Gerald Keith
    Silverwood
    Queens Drive
    KT22 0PB Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Silverwood
    Queens Drive
    KT22 0PB Oxshott
    Surrey
    BritishConsultant40829770001
    MACDIARMID, James David
    74 Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BU London
    Administrateur
    74 Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BU London
    EnglandBritishFinance Director209469010001
    MANN, David Preston
    10 St Mary Axe
    EC3A 8NA London
    Fitzwilliam House
    Administrateur
    10 St Mary Axe
    EC3A 8NA London
    Fitzwilliam House
    United KingdomBritishCompany Director17004950004
    MERRY, Barbara Jane
    St. Clere Hill Road
    West Kingsdown
    TN15 6AH Sevenoaks
    The Grange
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Clere Hill Road
    West Kingsdown
    TN15 6AH Sevenoaks
    The Grange
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive185383690001
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    Administrateur
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    United KingdomBritishBusinessman685750001
    ROSE, Kenneth Charles
    43a Braid Road
    EH10 6AW Edinburgh
    Administrateur
    43a Braid Road
    EH10 6AW Edinburgh
    BritishSolicitor46168750002
    THOMAS, Barbara Sue, The Hon
    3 Chester Street
    SW14 7BB London
    Administrateur
    3 Chester Street
    SW14 7BB London
    U S ACompany Director96797470001
    VAN DER MERSCH, Pierre Emile Leon Marie
    Dreve Du Bois De Mai 2
    1428 Braine L'Alleud
    FOREIGN Belgium
    Administrateur
    Dreve Du Bois De Mai 2
    1428 Braine L'Alleud
    FOREIGN Belgium
    BelgianDirector43752770001
    WADMAN, Stephen Noel
    8 Fernlea Road
    CM0 8EJ Burnham On Crouch
    Essex
    Administrateur
    8 Fernlea Road
    CM0 8EJ Burnham On Crouch
    Essex
    BritishUnderwriting Director40829610001
    WALKER, Adrian Jeremy
    Upland House, Saxham Street
    Stowupland
    IP14 5DD Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Upland House, Saxham Street
    Stowupland
    IP14 5DD Stowmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishUnderwriter4205230002
    WELDON, Steuart William Pratchitt
    Priors Barn
    Hall Lane, Upper Farringdon
    GU34 3EA Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Priors Barn
    Hall Lane, Upper Farringdon
    GU34 3EA Alton
    Hampshire
    BritishBusinessman44866610002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hardy Underwriting Bermuda Limited
    50 Cedar Avenue
    Hamilton
    Crawford House
    Bermuda
    06 avr. 2016
    50 Cedar Avenue
    Hamilton
    Crawford House
    Bermuda
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementBermuda
    Autorité légaleBermuda
    Lieu d'enregistrementBermuda
    Numéro d'enregistrement40834
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Cna Financial Corporation
    1209 Orange Street
    Wilmington
    Corporation Trust Center
    Delaware
    United States
    06 avr. 2016
    1209 Orange Street
    Wilmington
    Corporation Trust Center
    Delaware
    United States
    Non
    Forme juridiqueCorporation
    Pays d'enregistrementUnited States
    Autorité légaleDelaware
    Lieu d'enregistrementDelaware
    Numéro d'enregistrement662910
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    HARDY UNDERWRITING GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 août 2013
    Livré le 05 sept. 2013
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's, the Beneficiaries and the Other Persons or Bodies (As Further Defined on Form MR01)
    Transactions
    • 05 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 12 nov. 2009
    Livré le 19 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Trustee)
    Transactions
    • 19 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 15 nov. 2006
    Livré le 15 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Trustee)
    Transactions
    • 15 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 nov. 2002
    Livré le 12 nov. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and uncalled capital, the investments, the shares all dividends interest and other monies , all monetary claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 14 oct. 2002
    Livré le 18 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871 by the Name of Lloyd's
    Transactions
    • 18 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 12 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit trust deed (third party deposit)(the "trust deed")
    Créé le 01 janv. 1997
    Livré le 17 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of hardy names limited(the "company") incurred by the "company" as an underwriting member of the society at any time before the termination date (being the 80TH anniversary of the date of the trust deed) including obligations to the society and the trustee (being the society and the other trustees for the time being of the trusts created by the trust deeds) and obligations arising under (a) the bye laws regulations rules directions or other requirements of the society and (b) any deed contract instrument or other arrangement of any kind approved by the society but not including obligations arising in respect of any letter of credit guarantee or other security given to secure the performance of any of the said underwriting obligations in favour of the person giving such guarantee or other security
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees upon the trusts of the trust deed and all accumulations of income and the investments and other property after the date of the trust deed for the time being representing the same.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds's ("the Society"), the Trustees and the Beneficiaries and the Premiums Trusteesand the Other Persons or Bodies as are Defined on the Form M395
    Transactions
    • 17 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Deposit trust deed (third party deposit) (the "trust deed")
    Créé le 01 janv. 1997
    Livré le 17 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All the underwriting obligations of hardy names limited(the "company") incurred by the "company" as an underwriting member of the society at any time before the termination date (being the 80TH anniversary of the date of the trust deed) including obligations to the society and the trustee (being the society and the other trustees for the time being of the trusts created by the trust deeds) and obligations arising under (a) the bye laws regulations rules directions or other requirements of the society and (b) any deed contract instrument or other arrangement of any kind approved by the society but not including obligations arising in respect of any letter of credit guarantee or other security given to secure the performance of any of the said underwriting obligations in favour of the person giving such guarantee or other security
    Brèves mentions
    All moneys or other property after the date of the trust deed at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees upon the trusts of the trust deed and all accumulations of income and the investments and other property after the date of the trust deed for the time being representing the same.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds's ("the Society"), the Trustees and the Beneficiaries and the Premiums Trusteesand the Other Persons or Bodies as are Defined on the Form M395
    Transactions
    • 17 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0