PHIP CH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPHIP CH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03217536
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PHIP CH LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PHIP CH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PHIP CH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CATHEDRAL HEALTHCARE LIMITED11 mai 200411 mai 2004
    MOUNT ANVIL HEALTHCARE LIMITED12 mai 199912 mai 1999
    PRIMARY PARTNERSHIPS LIMITED01 mai 199801 mai 1998
    ANVIL LONDON LIMITED27 juin 199627 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de PHIP CH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour PHIP CH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Mr David Christopher Austin en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy David Walker Arnott en tant que directeur le 01 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Howell en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip John Holland en tant que directeur le 01 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip John Holland le 08 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juil. 2015

    État du capital au 10 juil. 2015

    • Capital: GBP 1,333
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2014

    État du capital au 30 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,333
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy David Walker Arnott le 01 mai 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy David Walker Arnott le 22 juil. 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Nexus Management Services Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de * Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* le 07 mai 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Margaret Vaughan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de J O Hambro Capital Management Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 22 juil. 2013

    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PHIP CH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Secrétaire
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4187765
    57253330002
    AUSTIN, David Christopher
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish131339590001
    HOWELL, Richard
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Administrateur
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish35560380005
    DEAMER, Kenneth
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    Secrétaire
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    British8521670002
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Irish47179960002
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    STEVENS, Philip Martin
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    British102528350001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Secrétaire
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2176004
    117915530003
    BENNETT, Barry John
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomIrish14707370002
    BORER, Derek
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    British60451400001
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Administrateur
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish53684400001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Administrateur
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish163838050001
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomIrish47179960002
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    Administrateur
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritish141827450001
    NEWMAN, Victor Edward
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    Administrateur
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    British23635170001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish81998190003
    UPTON, Richard
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    Administrateur
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    EnglandBritish204950320001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Administrateur
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish123167120001
    WALKER ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Administrateur
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish61889360004
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PHIP CH LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Primary Health Properties Plc
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    01 juin 2016
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement3033634
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    PHIP CH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2012
    Livré le 04 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 04 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 mars 2008
    Livré le 28 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transactions
    • 28 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2008
    • 16 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Créé le 01 juin 2007
    Livré le 14 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transactions
    • 14 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 juin 2007
    Livré le 14 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2006
    Livré le 15 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 janv. 2006
    Livré le 17 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 2006
    Livré le 11 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 02 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0