PHIP CH LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PHIP CH LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03217536 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PHIP CH LIMITED ?
| Adresse du siège social | 5th Floor Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PHIP CH LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour PHIP CH LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 8 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Nomination de Mr David Christopher Austin en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy David Walker Arnott en tant que directeur le 01 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Howell en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip John Holland en tant que directeur le 01 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip John Holland le 08 juil. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy David Walker Arnott le 01 mai 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy David Walker Arnott le 22 juil. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Nexus Management Services Limited en tant que secrétaire | 3 pages | AP04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* le 07 mai 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Margaret Vaughan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de J O Hambro Capital Management Limited en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PHIP CH LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England |
| 57253330002 | ||||||||||
| AUSTIN, David Christopher | Administrateur | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England | United Kingdom | British | 131339590001 | |||||||||
| HOWELL, Richard | Administrateur | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England | England | British | 164790590001 | |||||||||
| HYMAN, Harry Abraham | Administrateur | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | 35560380005 | |||||||||
| DEAMER, Kenneth | Secrétaire | Lucky Stones Rowhill Road DA2 7QQ Wilmington Kent | British | 8521670002 | ||||||||||
| HURLEY, Cornelius Killian | Secrétaire | 28 Millenium Wharf WD3 1AZ Rickmansworth Hertfordshire | Irish | 47179960002 | ||||||||||
| SCOTT, Christopher Richard | Secrétaire | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | British | 81998190003 | ||||||||||
| STEVENS, Philip Martin | Secrétaire | Forge House Maiden Street Weston SG4 7AA Hitchin Hertfordshire | British | 102528350001 | ||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Secrétaire | 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ground Floor, Ryder Court England |
| 117915530003 | ||||||||||
| BENNETT, Barry John | Administrateur | Meadowdown Doggetts Wood Close HP8 4TL Chalfont St. Giles Buckinghamshire | United Kingdom | Irish | 14707370002 | |||||||||
| BORER, Derek | Administrateur | 133 Ridge Lane WD17 4SX Watford Hertfordshire | British | 60451400001 | ||||||||||
| HAMBRO, James Daryl | Administrateur | Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street SW1Y 6QB London | United Kingdom | British | 53684400001 | |||||||||
| HOLLAND, Philip John | Administrateur | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | 163838050001 | |||||||||
| HURLEY, Cornelius Killian | Administrateur | 28 Millenium Wharf WD3 1AZ Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | Irish | 47179960002 | |||||||||
| ISAACS, Paul Samuel | Administrateur | Rosemead Woodhill Road CM3 4DY Danbury Essex | England | British | 141827450001 | |||||||||
| NEWMAN, Victor Edward | Administrateur | 70 Oakfield Road Southgate N14 6LX London | British | 23635170001 | ||||||||||
| SCOTT, Christopher Richard | Administrateur | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | England | British | 81998190003 | |||||||||
| UPTON, Richard | Administrateur | Old Bearhurst Battenhurst Road TN5 7DU Stonegate East Sussex | England | British | 204950320001 | |||||||||
| VAUGHAN, Margaret Helen | Administrateur | Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street SW1Y 6QB London | United Kingdom | British | 123167120001 | |||||||||
| WALKER ARNOTT, Timothy David | Administrateur | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | United Kingdom | British | 61889360004 | |||||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PHIP CH LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Health Properties Plc | 01 juin 2016 | 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor Greener House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PHIP CH LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 02 avr. 2012 Livré le 04 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 17 mars 2008 Livré le 28 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating security agreement | Créé le 01 juin 2007 Livré le 14 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 01 juin 2007 Livré le 14 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 13 juin 2006 Livré le 15 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 09 janv. 2006 Livré le 17 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 09 janv. 2006 Livré le 11 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 nov. 2004 Livré le 02 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0