DCS SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDCS SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03218909
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DCS SERVICES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe DCS SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DCS SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour DCS SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    legacy

    pages652a

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages190

    legacy

    pages353

    legacy

    pages287

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    pagesAA

    legacy

    pages287

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288b

    Démission de l'auditeur

    pagesAUD

    legacy

    pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    pagesAA

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    Qui sont les dirigeants de DCS SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Secrétaire
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    American121496770001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Administrateur
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121495910001
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Administrateur
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121496770001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BYGRAVE, Susan Jane
    2 The Mill
    Hertingfordbury
    SG14 2SB Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    2 The Mill
    Hertingfordbury
    SG14 2SB Hertford
    Hertfordshire
    British114989650001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Secrétaire
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    ROGERS, Wendy Fiona
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    British72773920003
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ARROWSMITH, Robert George
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    Administrateur
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    United KingdomBritish70780350004
    FABRE, Jeremie
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    Administrateur
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    French116364550001
    FORSYTH, Andrew James
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish64591610001
    GUJRAL, Ben
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    British94654870001
    LODGE, Robin Wilfred Ian
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    Administrateur
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    SwitzerlandBritish154369990002
    ROBINSON, Timothy Michael
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    EnglandBritish154155330001
    SAVAGE, John Richard
    Primrose Bank Brooks Lane
    Bosley
    SK11 0PU Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Primrose Bank Brooks Lane
    Bosley
    SK11 0PU Macclesfield
    Cheshire
    British61675390001
    STERKENBURG, Daniel Richard
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    Administrateur
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    American116364510001
    WILLIAMS, Robert George
    Daneport Lodge
    30 Church Lane
    HG3 1NQ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Daneport Lodge
    30 Church Lane
    HG3 1NQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish95071890001
    YAPP, Stephen
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    Administrateur
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish42686850001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    DCS SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 mars 2004
    Livré le 01 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 20 déc. 2001
    Livré le 04 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £94,615 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £94,615 and any interest accrued thereon which has not been paid to the company.
    Personnes ayant droit
    • Penson Worldwide Settlements Limited
    Transactions
    • 04 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 05 juin 2000
    Livré le 13 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 févr. 1998
    Livré le 27 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0