TRANSACSYS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRANSACSYS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03221130
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRANSACSYS LIMITED ?

    • (7260) /

    Où se situe TRANSACSYS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRANSACSYS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRANSACSYS PLC06 avr. 200006 avr. 2000
    GIROVEND CASHLESS SYSTEMS PLC21 févr. 199721 févr. 1997
    ROBINBUY PLC05 juil. 199605 juil. 1996

    Quels sont les derniers comptes de TRANSACSYS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour TRANSACSYS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2010 avec liste étendue des actionnaires

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 juil. 2010

    État du capital au 22 juil. 2010

    • Capital: GBP 2,428,705.65
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2009

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Smyth en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    8 pages363a

    legacy

    8 pages363a

    legacy

    8 pages363a

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de TRANSACSYS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Secrétaire
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Administrateur
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    British49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HARRINGTON, Michael
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    Secrétaire
    28 Arlington Avenue
    N1 7AX London
    British42936520001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Secrétaire
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Secrétaire
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    British78149370002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Administrateur
    75 Park Road
    W4 3EY London
    EnglandBritish37599910001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Administrateur
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BRIGHT, Keith, Sir
    16 Westbourne Park Villas
    W2 5EA London
    Administrateur
    16 Westbourne Park Villas
    W2 5EA London
    United KingdomBritish1770160001
    CLARK, Ronald Thomson
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    British69705410001
    CLYDE, James Donald Laurence
    12 Arundel Gardens
    W11 2LA London
    Greater London
    Administrateur
    12 Arundel Gardens
    W11 2LA London
    Greater London
    British54439570001
    DITCHBURN, John Blackett Dennison
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British61233990002
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish49907850002
    GAHAGNON, Jacques Andre
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    Administrateur
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    French68163380001
    GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    Administrateur
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    British89929500001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    LAING, Andrew Murray
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    Administrateur
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    British28771390001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MASSEY, Peter Derek
    Pullington House Pullington Cottages
    Benenden
    TN17 4EH Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Pullington House Pullington Cottages
    Benenden
    TN17 4EH Cranbrook
    Kent
    British42440170003
    MCGRANE, Paul Steven
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    Administrateur
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    United KingdomBritish51004210002
    MCNAIR, Iain
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    Administrateur
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    British85499250001
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Administrateur
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Administrateur
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Administrateur
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Administrateur
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    NEWMARCH, Michael George
    7 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Administrateur
    7 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    British1109560005
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Administrateur
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    EnglandBritish78149370002
    SALMON, Claire Louise
    Flat 2
    47 Montagu Square
    W1H 1TH London
    Administrateur
    Flat 2
    47 Montagu Square
    W1H 1TH London
    British70197550002
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Administrateur
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMART, Richard Ernest
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    British7970090001

    TRANSACSYS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Accession deed to an intercreditor deed
    Créé le 21 févr. 2006
    Livré le 07 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By clause 5.1 (turnover: turnover obligations) of the deed until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments, it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the chargee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the chargee, the additional obligor shall hold the same on trust for the application by the chargee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Syndicated debenture
    Créé le 21 févr. 2006
    Livré le 07 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustee for Thebeneficiaries
    Transactions
    • 07 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 juil. 2005
    Livré le 15 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 15 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 15 oct. 1999
    Livré le 27 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (formerly known as girovend cashless systems PLC) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights, title and interest in the assigned cash (as defined in the rent deposit deed) and the debts represented by it.
    Personnes ayant droit
    • Madge Networks Limited
    Transactions
    • 27 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 1997
    Livré le 11 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies mentioned therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All f/h and l/h land in england and wales now vested in the company including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0