BMG (MANSFIELD) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BMG (MANSFIELD) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03224318 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BMG (MANSFIELD) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BMG (MANSFIELD) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour BMG (MANSFIELD) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 03 mai 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Poultry London EC2R 8EJ à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 06 janv. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination de Mrs Rowan Tracy Hostler en tant qu'administrateur le 09 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Anthony Diemer en tant que directeur le 09 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Barry Steven Hill en tant que directeur le 09 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Rowley Rose en tant qu'administrateur le 09 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juil. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Barry Steven Hill en tant qu'administrateur le 20 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Justin Mark Brand en tant que directeur le 10 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Bryan Womack en tant que directeur le 30 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Anthony Diemer en tant qu'administrateur le 18 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 14 Cornhill London EC3V 3ND England à St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013 | 2 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Jones en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BMG (MANSFIELD) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom |
| 1278390004 | ||||||||||
| HOSTLER, Rowan Tracy | Administrateur | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 201266610001 | |||||||||
| ROSE, David Rowley | Administrateur | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||||||
| LEWIS, Maria Bernadette | Secrétaire | 1 Scriveners Close Hillfield Road HP2 4XP Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 54836960001 | ||||||||||
| WILLIAMS HAMER, Gabrielle Mary | Secrétaire | 25 Elspeth Road Battersea SW11 1DW London | British | 45555320001 | ||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||
| BECKETT, Barbara Ann | Administrateur | 3 Lees Cottages Pyrford Road GU22 8UF Woking Surrey | England | British | 36403110001 | |||||||||
| BENNETT, George Morgan | Administrateur | Flat 22 35 Grosvenor Square W1 London | United States | 50870930001 | ||||||||||
| BRAND, Justin Mark | Administrateur | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | England | English | 254970510001 | |||||||||
| CALABRESE, Julia Jean | Administrateur | 14 Hans Crescent SW1X 0LJ London | United Kingdom | American | 63214460001 | |||||||||
| COPPOCK, Lawrence Patrick | Administrateur | The Close Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | England | United Kingdom | 152718990001 | |||||||||
| DIEMER, David Anthony | Administrateur | Poultry EC2R 8EJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 79053460001 | |||||||||
| EDINGTON, George Gordon | Administrateur | 7 St Simons Avenue Putney SW15 6DU London | United Kingdom | British | 1386790001 | |||||||||
| GIBSON, John Michael Barry | Administrateur | 51 Lower Belgrave Street SW1W 0LP London | British | 82660110001 | ||||||||||
| GOTTLIEB, Julius | Administrateur | 8 Southway Totteridge N20 8EA London | England | British | 32807790002 | |||||||||
| HILL, Barry Steven | Administrateur | Poultry EC2R 8EJ London 1 | United Kingdom | British | 165034590001 | |||||||||
| JONES, Peter Joseph | Administrateur | 8 Montpelier Villas BN1 3DH Brighton East Sussex | British | 49764720002 | ||||||||||
| JONES, Richard Peter | Administrateur | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | England | British | 76584200002 | |||||||||
| KAEMPFER, Joseph Wallach | Administrateur | 15 Blomfield Road W9 1AD London | United Kingdom | American | 48577420002 | |||||||||
| LAXTON, Chris James Wentworth | Administrateur | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | United Kingdom | British | 198871760001 | |||||||||
| LIGHTFOOT, William Vincent | Administrateur | Tipnoaks London Road BN6 9BJ Albourne West Sussex | British | 78739030001 | ||||||||||
| MANSLEY, Nicholas John Fermor | Administrateur | 4 Willis Road CB1 2AQ Cambridge | England | British | 73817060002 | |||||||||
| MURPHY, James Byrne | Administrateur | 14 Kensington Gate W8 5NA London | American | 50871010002 | ||||||||||
| NASH, Peter Baird | Administrateur | 91 Clifton Hill NW8 0JW London | American | 60917560001 | ||||||||||
| NICOLOSI, John | Administrateur | 2 Cambridge Terrace Regents Park NW1 4JL London | American | 67480450001 | ||||||||||
| RICKETTS, Brian Hugh | Administrateur | The Tudors Nyetimber Copse RH20 2NE West Chiltington West Sussex | British | 7340390001 | ||||||||||
| SAYERS, David | Administrateur | 32 The Chase RH2 7DH Reigate Surrey | British | 65829520001 | ||||||||||
| SOLLER, Brad | Administrateur | 53 Windermere Avenue Finchley N3 3RD London | British | 67373440001 | ||||||||||
| WADDELL, Ronald Winsor | Administrateur | 4 The Cloisters Forelands Way HP5 1QR Chesham Buckinghamshire | British | 34743860003 | ||||||||||
| WALLS, John Russell Fotheringham | Administrateur | 40 Ibis Lane Grove Park Chiswick W4 3UP London | United Kingdom | British | 43558350002 | |||||||||
| WISE, David Andrew | Administrateur | 5 Orchid Grange Orchid Road Southgate N14 5HH London | British | 74016310002 | ||||||||||
| WOMACK, Ian Bryan | Administrateur | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | England | British | 33902000006 | |||||||||
| WRIGHT, Adrian James | Administrateur | North Field House 9a Coniston Road CB1 4BZ Cambridge | British | 40406910001 | ||||||||||
| MIKJON LIMITED | Administrateur | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 44503290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BMG (MANSFIELD) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Designer Retail Outlet Centres (General Partner) Limited | 06 avr. 2016 | Poultry EC2R 8EJ London No. 1 England England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BMG (MANSFIELD) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Original debenture amendment and accession deed (for amending the debenture and security trust deed dated 23 june 1997) | Créé le 16 avr. 1999 Livré le 30 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 juin 1997 Livré le 02 juil. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any one of them pursuant to the bmg (mh) facility letter, the v&p facility letter or this debenture and on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 04 mars 1997 Livré le 06 mars 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti In favour of the chargee the property price as defined in an agreement dated 4TH march 1997 or such part as shall be outstanding from time to time and any interest thereon or in respect thereof | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage of land on the south east side of mansfield road south normanton bolsover derbyshire t/no.DY206374. By way of floating charge the company's undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
BMG (MANSFIELD) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0