SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED

SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03225331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LEGISLATOR 1282 LIMITED16 juil. 199616 juil. 1996

    Quels sont les derniers comptes de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    6 pages1.4

    Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 17 août 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juil. 2012

    État du capital au 17 juil. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    4 pages1.1

    Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    29 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Enter agreement 14/05/2010
    RES13

    Comptes annuels établis au 27 sept. 2009

    25 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kamma Foulkes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305990001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    O`REILLY, John
    35a Court Farm Road
    UB5 5HQ Northolt
    Middlesex
    Secrétaire
    35a Court Farm Road
    UB5 5HQ Northolt
    Middlesex
    British48337750001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    English51896650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secrétaire
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    STEVEN, Kenneth
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    British64425700001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Administrateur
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    British51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Administrateur
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MARSHALL, Diana Jane
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    Administrateur
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    British47799990002
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Administrateur
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    EnglandEnglish51896650001
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Administrateur
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Administrateur
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Administrateur
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STABLES, Trevor Leslie
    Sakura 9 Kingsmeadow
    Crudwell
    SN16 9HT Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Sakura 9 Kingsmeadow
    Crudwell
    SN16 9HT Malmesbury
    Wiltshire
    British51294380001
    STEVEN, Kenneth
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    British64425700001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Administrateur
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish80445640001

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 14 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 20 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 20 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 2005
    Livré le 15 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2004
    Livré le 28 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 28 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 août 2002
    Livré le 03 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transactions
    • 03 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third guarantee and debenture
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 30 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second guarantee and debenture
    Créé le 25 févr. 2002
    Livré le 11 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee (as security agent for the beneficiaries) (as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First guarantee and debenture
    Créé le 22 févr. 2002
    Livré le 01 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 01 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment by way of security
    Créé le 24 avr. 1998
    Livré le 09 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee by virtue of the legal charge dated 24TH april 1998
    Brèves mentions
    F/H property on the north west side of dod street stepney l/b of tower hamlets t/no: LN3733 together with all buildings and fixtures thereon and the goodwill of any business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 09 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 avr. 1998
    Livré le 08 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including f/h property on the north west side of dod street stepney l/b tower hamlets t/n LN3733. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 08 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 avr. 1998
    Livré le 08 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property on the north west side of dod street stepney l/b tower hamlets t/n LN3733 assigns the benefit of all present and future licences all compensation the goodwill of the business and the benefit of all guarantees or covenants.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 08 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE FACILITIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2012Date of meeting to approve CVA
    20 août 2012Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    practitioner
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0