INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 03225820 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST ?
| Adresse du siège social | Life Hub Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes consolidés établis au 31 mars 2025 | 57 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Cessation de la nomination de Louise Hunter en tant que directeur le 30 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Fiona Crozier le 03 déc. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kathryn Lucy Hay Winskell le 21 nov. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de David Roy Sandbach en tant que directeur le 31 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Councillor Andrew Ethan Herridge en tant qu'administrateur le 18 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2024 | 60 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Margaret Wood en tant que directeur le 03 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Joris Andre Veltman en tant que directeur le 23 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2023 | 60 pages | AA | ||
Nomination de Dr Laura Strain en tant qu'administrateur le 20 juil. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Mathan Kumar Ganesan en tant qu'administrateur le 30 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2022 | 62 pages | AA | ||
Nomination de Councillor Margaret Wood en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Irim Ali en tant que directeur le 20 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 2 pages | MR04 | ||
Cessation de la nomination de Elizabeth Louise Mayes en tant que directeur le 27 janv. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2021 | 60 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Management Suite Times Square Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE1 4EP à Life Hub Times Square Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE1 4EP le 23 juil. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Qui sont les dirigeants de INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS, Claire Helen | Secrétaire | 174 Great North Road Gosforth NE3 2DS Newcastle Upon Tyne | British | 44095000004 | ||||||
| CONLON, Delinda Virginia Julia | Administrateur | 214 Western Way Darras Hall NE20 9ND Ponteland Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 111193720001 | |||||
| CROZIER, Fiona | Administrateur | Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne Life Hub United Kingdom | England | British | 64929060005 | |||||
| DOWNES, John Robert | Administrateur | The Brambles New Hartley NE25 0RQ Whitley Bay 23 United Kingdom | United Kingdom | British | 285543000001 | |||||
| GANESAN, Mathan Kumar | Administrateur | Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne Life Hub United Kingdom | United Kingdom | British | 104156440004 | |||||
| HERRIDGE, Andrew Ethan, Councillor | Administrateur | Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne Life Hub United Kingdom | United Kingdom | British | 325901830001 | |||||
| ROBINSON, Jane Elizabeth, Prof. | Administrateur | Claremont Road NE1 7RU Newcastle Upon Tyne King's Gate United Kingdom | United Kingdom | British | 167865880001 | |||||
| RYAN, Mark | Administrateur | Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne Life Hub United Kingdom | United Kingdom | Irish | 285521300001 | |||||
| STONEHOUSE, Tracey Michelle | Administrateur | Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne Life Hub United Kingdom | England | British | 163369760001 | |||||
| STRAIN, Laura, Dr | Administrateur | Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne Life Hub United Kingdom | England | British | 311891390001 | |||||
| WINSKELL, Kathryn Lucy Hay | Administrateur | Times Square Scotswood Road NE1 4EP Newcastle Upon Tyne Life Hub United Kingdom | United Kingdom | British | 37961280005 | |||||
| KEAN, Donald John | Secrétaire | 22 Hawthorn Gardens NE26 3PQ Whitley Bay Tyne & Wear | British | 39691410001 | ||||||
| MCGILL, David John | Secrétaire | Lower Brunton Barns Humshaugh NE46 4EL Hexham Northumberland | British | 44264510001 | ||||||
| ALI, Irim | Administrateur | Middleton Avenue NE4 9NB Newcastle Upon Tyne 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 177314280001 | |||||
| APPLEGARTH, Adam John | Administrateur | Silverwood 37 Painshawfield Road NE43 7PX Stocksfield Northumberland | British | 36778940002 | ||||||
| ARMSTRONG, Ronald Dixon, Cllr | Administrateur | 73 Grosvenor Avenue Jesmond NE2 2NQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 96442620001 | |||||
| BALLS, Alastair Gordon | Administrateur | Oakwood House NE41 8BH Wylam Northumberland | England | British | 37191670001 | |||||
| BARTLETT, Christopher John, Cllr | Administrateur | The Cloisters NE7 7LS Newcastle Upon Tyne 47 Tyne And Wear Uk | Uk | British | 161885630001 | |||||
| BRINK, Chris Hendrik, Professor | Administrateur | Eland Lodge 16 North Road Ponteland NE20 9UH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British, South African, Australian | 133098830004 | |||||
| BUSHBY, Katharine Mary Dympna, Professor Emerita | Administrateur | Management Suite Times Square NE1 4EP Scotswood Road Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 260243040001 | |||||
| COOKSON, Clive Michael | Administrateur | Queen Annes Gardens W4 1TU London 5 | United Kingdom | British | 138300980001 | |||||
| COOPER, Quentin Charles | Administrateur | Whiteleaf HP27 0LL Princes Risborough Barn Cottage Bucks Uk | United Kingdom | British | 135208560001 | |||||
| DAVIES, Richard John, Professor | Administrateur | Kings Gate NE1 7RU Newcastle Upon Tyne Newcastle University England | England | British | 149615870001 | |||||
| DAY, Christopher Paul, Professor | Administrateur | The Medical School Newcastle University NE2 4HH Framlington Place Medical Sciences Faculty Office Newcastle Upon Tyne England | England | British | 158204560001 | |||||
| DEXTER, Thomas Michael, Dr | Administrateur | Ash Tree Farm Skellorn Green Adlington SK10 4NU Macclesfield Cheshire | British | 92028820001 | ||||||
| DONALDSON, Liam, Professor | Administrateur | 1 Beechways Whitesmocks DH1 4LG Durham City County Durham | British | 50567740001 | ||||||
| EDWARDS, Christopher, Professor | Administrateur | 6 Kensington Terrace NE1 7RU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 118583740001 | ||||||
| FELLS, Ian, Prof | Administrateur | 29 Rectory Terrace Gosforth NE3 1YB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 4300350001 | |||||
| FENWICK, Nicholas Adam Hodnett | Administrateur | 37 Redburn Street SW3 4DA London | United Kingdom | British | 63896150002 | |||||
| FISHER, Jackie | Administrateur | Church Lane Barn Allerwash NE47 5BJ Hexham Northumberland | England | British | 91826600001 | |||||
| FLYNN, Anthony Gerard, Councillor | Administrateur | 12 Dilston Terrace NE3 1XX Newcastle Upon Tyne | British | 45697900001 | ||||||
| FOSTER, John Robert | Administrateur | 22 The Greenway TS7 0DB Nunthorpe Middlesbrough | British | 92404660001 | ||||||
| GATER, Steven, Dr | Administrateur | 29 West Farm Court Broompark DH7 7RN Durham County Durham | England | British | 113164760001 | |||||
| GIBSON, Ian, Sir | Administrateur | 21 Montagu Avenue NE3 4HY Gosforth Tyne & Wear | United Kingdom | British | 113030300001 | |||||
| HARRISON, Terence, Sir | Administrateur | 2 The Garden House NE61 3UZ Whalton Northumberland | British | 7573800003 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour INTERNATIONAL CENTRE FOR LIFE TRUST ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 11 juil. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0