DESIGN OBJECTIVES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | DESIGN OBJECTIVES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03225867 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?
Adresse du siège social | Highfield Court Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 janv. 2019 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 oct. 2019 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2018 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 juil. 2019 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 12 août 2019 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 juil. 2018 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal | 13 pages | LIQ10 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2024 | 15 pages | LIQ03 | ||||||||||
Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal | 10 pages | LIQ10 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2023 | 16 pages | LIQ03 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 032258670009 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 032258670010 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2022 | 16 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2021 | 16 pages | LIQ03 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2020 | 17 pages | LIQ03 | ||||||||||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 4 pages | NDISC | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 90 Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross Wimborne Dorset BH21 6SP à Highfield Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TY le 28 mars 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 9 pages | LIQ02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2018 | 29 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Natalie Galvin en tant que directeur le 19 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2017 | 30 pages | AA | ||||||||||
Cessation de Stephen David Barber en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2016 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 032258670007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Michael David Bray en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAY, Owen John | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court Hampshire | England | British | None | 221848180001 | ||||||||
PILLAI, Joanna Claire | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court Hampshire | England | British | None | 158885340001 | ||||||||
POWER, William George Charles | Administrateur | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court Hampshire | United Kingdom | British | None | 222021870001 | ||||||||
HAGUE, Andrew | Secrétaire | 14 Four Lane Close Chineham RG24 8RN Basingstoke Hampshire | British | Company Director | 3071270001 | |||||||||
JOY, Kevin Antony | Secrétaire | Laurel Way Charlton Down DT2 9XU Dorchester 1 Dorset England | 198742660001 | |||||||||||
SHUREY, Vanessa | Secrétaire | 5 Pinehurst Road West Moors BH22 0AH Ferndown Dorset | British | Accountant | 101259010001 | |||||||||
WASHINGTON, William Irving | Secrétaire | 3 Essex Place Lambourn RG17 8QF Hungerford Berkshire | British | 92488210001 | ||||||||||
LESTER ALDRIDGE (SECRETARIAL) LIMITED | Secrétaire | Russell House Oxford Road BH8 8EX Bournemouth Dorset | 4056160001 | |||||||||||
ADIE, Alison | Administrateur | 12 Sandringham Drive Beeston NG9 3ED Nottingham | British | Non-Executive Director | 49276730001 | |||||||||
BARRATT, Susan Catherine | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | England | British | Sales Director | 135748320002 | ||||||||
BOWLES, Terence John | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | United Kingdom | British | Distribution | 60618990001 | ||||||||
COX, Richard John | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | United Kingdom | British | Sales Director | 186774260001 | ||||||||
DALER, James Arthur Terence | Administrateur | Westholme Manor West Holme BH20 6AQ Wareham Dorset | England | British | Company Director | 20583100001 | ||||||||
DALER, James Arthur Terence | Administrateur | Westholme Manor West Holme BH20 6AQ Wareham Dorset | England | British | Company Director | 20583100001 | ||||||||
DALEY, Clive Frederick | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | England | British | Ceo | 130231710005 | ||||||||
GALVIN, Natalie | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | England | British | Chief Executive | 184411720001 | ||||||||
GALVIN, Natalie | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | England | British | Ceo | 184411720001 | ||||||||
HAGUE, Andrew | Administrateur | 14 Four Lane Close Chineham RG24 8RN Basingstoke Hampshire | British | Company Director | 3071270001 | |||||||||
JOY, Kevin Antony | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | England | English | Finance Director | 200342630001 | ||||||||
KNOWLES, Andrew James | Administrateur | 11 Cassel Avenue BH13 6JD Poole Dorset | British | Managing Director | 68527660002 | |||||||||
MCDONALD, John Frederick | Administrateur | 4060 Runneymead Drive Lilburn Georgia 30247/3369 Usa | Us | Co President | 49192280001 | |||||||||
PIPERNO, Adolph Joseph | Administrateur | 122 Hart Road 08034 Cherry Hill New Jersey Usa | American | Company President | 49592440001 | |||||||||
SHUREY, Vanessa | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | England | British | None | 150430260001 | ||||||||
WOOD, Jonathan Ross | Administrateur | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | England | British | Company Director | 101242550002 | ||||||||
DESIGN OBJECTIVES (HOLDINGS) LIMITED | Administrateur | Old Barn Farm Road Woolsbridge Industrial Estate, Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 England |
| 215615560001 | ||||||||||
LESTER ALDRIDGE (MANAGEMENT) LIMITED | Administrateur | Russell House Oxford Road BH8 8EX Bournemouth | 43643830001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Stephen David Barber | 06 avr. 2016 | Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross BH21 6SP Wimborne Unit 90 Dorset | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Michael David Bray | 06 avr. 2016 | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court Hampshire | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
|
DESIGN OBJECTIVES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 31 janv. 2017 Livré le 02 févr. 2017 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 15 sept. 2015 Livré le 15 sept. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 14 juil. 2015 Livré le 17 juil. 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 14 juil. 2015 Livré le 14 juil. 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 28 juin 2013 Livré le 02 juil. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description By way of fixed charge the following property of the company owned now or in the future:-. (I) all interests in any heritable freehold or leasehold land (land) vested in or charged to the company, all fixtures and fittings attached to that land and all rents receivable from any lease granted out of that land;. (Ii) all plant and machinery, including any associated warranties and maintenance contracts;. (Iii) all the goodwill of the company's business;. (Iv) any uncalled capital;. (V) all stock, shares and other securities held by the company at any time in any subsidiary and all income and rights relating to those stocks, shares and securities;. (Vi) all intellectual property, licences, claims, insurance policies, proceeds of any insurance and any other legal rights;. (Vii) the benefit of any hedging arrangements, futures transactions or treasury instruments;. (Viii) all debts which fail to vest in the bank (rbsif) under any debt purchase facility entered into between the company and the bank (rbsif) (debt purchase facility) and their related rights (as defined in the debt purchase agreement). 2 by way of floating charge all the other property assets and rights of the company owned now or in the future which are not subject to an effective fixed charge under the debenture or any other security held by the bank.. Note 1: the debenture contains covenants by the company that the company will not without the bank's consent:-. (A) permit or create any mortgage, standard security, charge or lien on the property;. (B) dispose of the property of the company, owned now or in the future, charged by way of fixed charge;. (C) dispose of the property, other than in the ordinary course of business, charged by way of floating charge;. (D) call on, or accept payment of, any uncalled capital;. (E) grant, or accept a surrender of, any lease or licence of any of its land or consent to a tenant assigning or sub letting;. (F) dispose of, part with or share possession or occupation of any of its land.. Note 2: the debenture gives the bank power to appoint an administrator.. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 11 août 2006 Livré le 17 août 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 30 sept. 2005 Livré le 08 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All deposits now and in the future credited to account designation 10044918 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 13 juil. 2005 Livré le 16 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 juin 2005 Livré le 06 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 déc. 2002 Livré le 24 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
DESIGN OBJECTIVES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0