DESIGN OBJECTIVES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDESIGN OBJECTIVES LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03225867
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Highfield Court Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HONEYCOMBE 64 LIMITED17 juil. 199617 juil. 1996

    Quels sont les derniers comptes de DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 janv. 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 juil. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation12 août 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 juil. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    13 pagesLIQ10

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2024

    15 pagesLIQ03

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    10 pagesLIQ10

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2023

    16 pagesLIQ03

    Satisfaction de la charge 032258670009 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032258670010 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2022

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2021

    16 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 28 févr. 2019

    LRESEX

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2020

    17 pagesLIQ03

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Changement d'adresse du siège social de Unit 90 Woolsbridge Industrial Estate Three Legged Cross Wimborne Dorset BH21 6SP à Highfield Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TY le 28 mars 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration des affaires

    9 pagesLIQ02

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2018

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Natalie Galvin en tant que directeur le 19 mars 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2017

    30 pagesAA

    Cessation de Stephen David Barber en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2016

    1 pagesPSC07

    Satisfaction de la charge 032258670007 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 29 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Michael David Bray en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01

    Qui sont les dirigeants de DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRAY, Owen John
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    EnglandBritishNone221848180001
    PILLAI, Joanna Claire
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    EnglandBritishNone158885340001
    POWER, William George Charles
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    Administrateur
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    United KingdomBritishNone222021870001
    HAGUE, Andrew
    14 Four Lane Close
    Chineham
    RG24 8RN Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    14 Four Lane Close
    Chineham
    RG24 8RN Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director3071270001
    JOY, Kevin Antony
    Laurel Way
    Charlton Down
    DT2 9XU Dorchester
    1
    Dorset
    England
    Secrétaire
    Laurel Way
    Charlton Down
    DT2 9XU Dorchester
    1
    Dorset
    England
    198742660001
    SHUREY, Vanessa
    5 Pinehurst Road
    West Moors
    BH22 0AH Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    5 Pinehurst Road
    West Moors
    BH22 0AH Ferndown
    Dorset
    BritishAccountant101259010001
    WASHINGTON, William Irving
    3 Essex Place
    Lambourn
    RG17 8QF Hungerford
    Berkshire
    Secrétaire
    3 Essex Place
    Lambourn
    RG17 8QF Hungerford
    Berkshire
    British92488210001
    LESTER ALDRIDGE (SECRETARIAL) LIMITED
    Russell House
    Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    Dorset
    Secrétaire
    Russell House
    Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    Dorset
    4056160001
    ADIE, Alison
    12 Sandringham Drive
    Beeston
    NG9 3ED Nottingham
    Administrateur
    12 Sandringham Drive
    Beeston
    NG9 3ED Nottingham
    BritishNon-Executive Director49276730001
    BARRATT, Susan Catherine
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    EnglandBritishSales Director135748320002
    BOWLES, Terence John
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    United KingdomBritishDistribution60618990001
    COX, Richard John
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    United KingdomBritishSales Director186774260001
    DALER, James Arthur Terence
    Westholme Manor
    West Holme
    BH20 6AQ Wareham
    Dorset
    Administrateur
    Westholme Manor
    West Holme
    BH20 6AQ Wareham
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director20583100001
    DALER, James Arthur Terence
    Westholme Manor
    West Holme
    BH20 6AQ Wareham
    Dorset
    Administrateur
    Westholme Manor
    West Holme
    BH20 6AQ Wareham
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director20583100001
    DALEY, Clive Frederick
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    EnglandBritishCeo130231710005
    GALVIN, Natalie
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    EnglandBritishChief Executive184411720001
    GALVIN, Natalie
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    EnglandBritishCeo184411720001
    HAGUE, Andrew
    14 Four Lane Close
    Chineham
    RG24 8RN Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    14 Four Lane Close
    Chineham
    RG24 8RN Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director3071270001
    JOY, Kevin Antony
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    EnglandEnglishFinance Director200342630001
    KNOWLES, Andrew James
    11 Cassel Avenue
    BH13 6JD Poole
    Dorset
    Administrateur
    11 Cassel Avenue
    BH13 6JD Poole
    Dorset
    BritishManaging Director68527660002
    MCDONALD, John Frederick
    4060 Runneymead Drive
    Lilburn
    Georgia
    30247/3369
    Usa
    Administrateur
    4060 Runneymead Drive
    Lilburn
    Georgia
    30247/3369
    Usa
    UsCo President49192280001
    PIPERNO, Adolph Joseph
    122 Hart Road
    08034 Cherry Hill
    New Jersey
    Usa
    Administrateur
    122 Hart Road
    08034 Cherry Hill
    New Jersey
    Usa
    AmericanCompany President49592440001
    SHUREY, Vanessa
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    EnglandBritishNone150430260001
    WOOD, Jonathan Ross
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Administrateur
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director101242550002
    DESIGN OBJECTIVES (HOLDINGS) LIMITED
    Old Barn Farm Road
    Woolsbridge Industrial Estate, Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    England
    Administrateur
    Old Barn Farm Road
    Woolsbridge Industrial Estate, Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05890219
    215615560001
    LESTER ALDRIDGE (MANAGEMENT) LIMITED
    Russell House Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    Administrateur
    Russell House Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    43643830001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DESIGN OBJECTIVES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Stephen David Barber
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    06 avr. 2016
    Woolsbridge Industrial Estate
    Three Legged Cross
    BH21 6SP Wimborne
    Unit 90
    Dorset
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Michael David Bray
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    06 avr. 2016
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    Hampshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    DESIGN OBJECTIVES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 31 janv. 2017
    Livré le 02 févr. 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 02 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 oct. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 sept. 2015
    Livré le 15 sept. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 oct. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 juil. 2015
    Livré le 17 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Peter Crossley
    • Stephen Barber
    Transactions
    • 17 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 24 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 juil. 2015
    Livré le 14 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited (Company Number 00620951)
    Transactions
    • 14 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 juin 2013
    Livré le 02 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    By way of fixed charge the following property of the company owned now or in the future:-. (I) all interests in any heritable freehold or leasehold land (land) vested in or charged to the company, all fixtures and fittings attached to that land and all rents receivable from any lease granted out of that land;. (Ii) all plant and machinery, including any associated warranties and maintenance contracts;. (Iii) all the goodwill of the company's business;. (Iv) any uncalled capital;. (V) all stock, shares and other securities held by the company at any time in any subsidiary and all income and rights relating to those stocks, shares and securities;. (Vi) all intellectual property, licences, claims, insurance policies, proceeds of any insurance and any other legal rights;. (Vii) the benefit of any hedging arrangements, futures transactions or treasury instruments;. (Viii) all debts which fail to vest in the bank (rbsif) under any debt purchase facility entered into between the company and the bank (rbsif) (debt purchase facility) and their related rights (as defined in the debt purchase agreement). 2 by way of floating charge all the other property assets and rights of the company owned now or in the future which are not subject to an effective fixed charge under the debenture or any other security held by the bank.. Note 1: the debenture contains covenants by the company that the company will not without the bank's consent:-. (A) permit or create any mortgage, standard security, charge or lien on the property;. (B) dispose of the property of the company, owned now or in the future, charged by way of fixed charge;. (C) dispose of the property, other than in the ordinary course of business, charged by way of floating charge;. (D) call on, or accept payment of, any uncalled capital;. (E) grant, or accept a surrender of, any lease or licence of any of its land or consent to a tenant assigning or sub letting;. (F) dispose of, part with or share possession or occupation of any of its land.. Note 2: the debenture gives the bank power to appoint an administrator.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 02 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 août 2006
    Livré le 17 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of deposit
    Créé le 30 sept. 2005
    Livré le 08 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 10044918 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 13 juil. 2005
    Livré le 16 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 16 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 06 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 2002
    Livré le 24 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DESIGN OBJECTIVES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 févr. 2019Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Patrick Brewer
    Highfield Court Tollgate
    Chandler'S Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    practitioner
    Highfield Court Tollgate
    Chandler'S Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    Alexander Kinninmonth
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    practitioner
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    James Hawksworth
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    practitioner
    Davidson House Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Gareth Harris
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Matthew Richard Meadley Wild
    Third Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    practitioner
    Third Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0