NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED

NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03225966
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BEGBIES TRAYNOR
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    K & S (277) LIMITED17 juil. 199617 juil. 1996

    Quels sont les derniers comptes de NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mai 2015

    15 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    29 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    29 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Changement d'adresse du siège social de The Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane Stoke-on-Trent Staffordshire ST3 6HP à C/O Begbies Traynor 340 Deansgate Manchester M3 4LY le 12 juin 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mai 2014

    19 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mai 2013

    18 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * 31 Ironmarket Newcastle Under Lyme Staffordshire ST5 1RP* le 21 mai 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination de Matthew Hunt en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2010

    État du capital au 05 août 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    25 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Newstead Properties Developments Limited le 06 juil. 2010

    2 pagesCH02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    25 pagesAA

    legacy

    7 pagesMG01

    Cessation de la nomination de John Hardacre en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FITZGERALD, Beverley
    Manor Hill Lordsley
    Ashley
    TF9 4EQ Market Drayton
    Salop
    Administrateur
    Manor Hill Lordsley
    Ashley
    TF9 4EQ Market Drayton
    Salop
    United KingdomBritishDirector59487020001
    HUNT, Matthew
    31 Ironmarket
    ST5 1RP Newcastle
    Queens Gardens Business Centre
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    31 Ironmarket
    ST5 1RP Newcastle
    Queens Gardens Business Centre
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishNone168539720001
    NEWSTEAD PROPERTIES DEVELOPMENTS LIMITED
    Ironmarket
    ST5 1RP Newcastle Under Lyme
    31
    Staffordshire
    Administrateur
    Ironmarket
    ST5 1RP Newcastle Under Lyme
    31
    Staffordshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02759066
    49589920002
    BELL, Anthony Peter
    65 Pembroke Court
    Pembroke Drive
    ST5 2JN Newcastle
    Staffordshire
    Secrétaire
    65 Pembroke Court
    Pembroke Drive
    ST5 2JN Newcastle
    Staffordshire
    British148444830001
    HARDACRE, John
    72 Beresford Crescent
    ST5 3RH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secrétaire
    72 Beresford Crescent
    ST5 3RH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishCompany Secretary49010920001
    K & S SECRETARIES LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Secrétaire désigné
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    900006940001
    FITZGERALD, David
    Manor Hill Lordsley
    Ashley
    TF9 4EQ Market Drayton
    Salop
    Administrateur
    Manor Hill Lordsley
    Ashley
    TF9 4EQ Market Drayton
    Salop
    BritishDirector14419000002
    HARDACRE, John
    72 Beresford Crescent
    ST5 3RH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    72 Beresford Crescent
    ST5 3RH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishAccountant49010920001
    K & S DIRECTORS LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Administrateur désigné
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    900006930001

    NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 22 oct. 2009
    Livré le 20 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming anniesland village business park, netherton road glasgow t/no's GLA158182, GLA18678 and GLA103262.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Assignation of rents
    Créé le 18 mai 2007
    Livré le 23 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to any lender on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests to the rents (the assigned rights). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited as Trustee for Itself and the Other Lenders from Time Totime (the Trustee)
    Transactions
    • 23 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Assignation of rents
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 07 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to any lender on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests present or future of the company to the rents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited as Trustee for Itself and the Other Lenders from Time Totime (the 'Trustee')
    Transactions
    • 07 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 23 december 2002 and
    Créé le 16 oct. 2002
    Livré le 11 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the trustee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Anniesland ind. Est. Netherton road glasgow part t/no GLA158182 and part t/no GLA103262 and part t/no GLA18678.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited as Trustee for Itself and the Other Lenders (Thetrustee)
    Transactions
    • 11 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD july 2000 and
    Créé le 20 juin 2000
    Livré le 07 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any group member to the chargee as trustees for itself and the other lenders from time to time on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole those subjects at anniesland industrial estate netherton road glasgow land registry no GLA103262.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 02 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 23 december 1997
    Brèves mentions
    The freehold land and buildings on the west side of darwen street blackburn title number LA563082 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 02 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security
    Créé le 24 déc. 1997
    Livré le 06 janv. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole that area of ground formerly k/a anniesland industrial estate and now being part of anniesland village business park nrtherton road glasgow t/n-GLA18678.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 06 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of legal charge
    Créé le 23 déc. 1997
    Livré le 09 janv. 1998
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by newstead properties limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of newstead properties limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the west side of long lane and land and buildings on the north side of hartley avenue fazakerley liverpool t/no.MS49804, all that f/h unit d crownhill estate plymouth t/no.DN354124, f/h land and buildings on the west side of darwen street blackburn t/no.LA563082 and all that land and buildings on the east side of currock road carlisle t/no.CU92603 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 09 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security dated 15TH august 1997 and presented for registration in scotland on the 4TH september 1997
    Créé le 04 sept. 1997
    Livré le 13 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this security and the facility agreement (as defined in the standard security deed)
    Brèves mentions
    All and whole that area of ground formerly k/a anniesland industrial estate and now forming part of anniesland village business park netherton road glasgow under consolidated title number GLA18678 but under exception of 1). all and whole the subjects k/a unit 13C anniesland village business park glasgow t/no;-gla 116168 2). all and whole the area of land forming part of anniesland village business park extending rto 1,000 square yards t/no;-gla 116162 to the extent that area 2). falls within the subjects register under t/no;-gla 18678 together with all and whole that area of ground extending to 8 acres and 28 decimal or one thousandth parts of an acre lying in the parish of new kilpatrick in the county of the barony and regality of glasgow and partly ion the county of dumbarton t/no;-103262 under exception of the area of ground registered under t/no;-GLA116162 to the extent that the ground fulls within t/no;-GLA103262 and all related rights and fixtures and fittinge thereof and thereon.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 19 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge the following properties:- transit way, crownhill, plymouth title number DN354124; aintree trading estate, long lane, liverpool title number MS49804; 16-26 darwen street, blackburn title number LA563082; currock road, carlisle title number CU92603 together with all rights powers easements and liberties attached or appurtenant to the said property and including also all buildings erected thereon and together also with all fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials (not being personal chattels within the bills of sale act 1878). assignment over al right title and interest in and to all rental income and all payments in respect of services and insurances.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 19 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 19 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over all the undertaking and assets.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 19 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard secuirty
    Créé le 28 oct. 1996
    Livré le 01 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of (a) facility letter dated 10TH october 1996; and (b) any letter, deed, document or other confirming, varying, amending or supplemental to the facility above
    Brèves mentions
    All and whole (first) all and whole that area of ground formerly k/a anniesland industrial estate and now forming part of anniesland village business park netherton road glasgow t/n-gla 18678.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge
    Créé le 25 oct. 1996
    Livré le 04 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property transit way, crownhill, plymouth; aintree trading estate, long lane, liverpool; 16 - 26 darwen street, blackburn t/nos: DN354124, MS49804 and LA563082. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 oct. 1996
    Livré le 04 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresover both present and future.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of rents
    Créé le 24 oct. 1996
    Livré le 01 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of (a) facility letter dated 10TH october 1996; and (b) any letter, deed, document or other confirming, varying, amending or supplemental to the facility letter above
    Brèves mentions
    Rents payable in respect of all property at anniesland industrial estate.
    Personnes ayant droit
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NEWSTEAD PROPERTIES FINANCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 mai 2012Commencement of winding up
    20 avr. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    practitioner
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    practitioner
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Dean Watson
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    practitioner
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Francesca Tackie
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    practitioner
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0