HAWKDECIDE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HAWKDECIDE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03231044 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HAWKDECIDE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 85 Springfield Road Chelmsford CM2 6JL Essex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HAWKDECIDE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour HAWKDECIDE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher William Goldsmith le 08 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008 | 11 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2006 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 395 | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 395 | ||||||||||
legacy | 8 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 8 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 8 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363s | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HAWKDECIDE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDSMITH, Christopher William | Administrateur | 85 Springfield Road Chelmsford CM2 6JL Essex | United Kingdom | British | 13230340005 | |||||
| BARNES, Sara Anne | Secrétaire | Parkfields Farm Beazley End CM7 5JJ Braintree Essex | British | 98921440001 | ||||||
| GOLDSMITH, Christopher William | Secrétaire | Ringers Farmhouse Terling Hall Road CM3 2BX Terling Essex | British | 13230340005 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARNES, Sara Anne | Administrateur | Parkfields Farm Beazley End CM7 5JJ Braintree Essex | United Kingdom | British | 98921440001 | |||||
| CARTER, Andrew Stewart | Administrateur | 55 Gracechurch Street EC3V 0UF London | United Kingdom | British | 145669000001 | |||||
| CARTER, Andrew Stewart | Administrateur | 55 Gracechurch Street EC3V 0UF London | United Kingdom | British | 145669000001 | |||||
| HOLMES, Colin Robert | Administrateur | Chantry Mid Meadow Hungate Lane NR34 9TP Beccles Suffolk | United Kingdom | British | 8041680001 | |||||
| HUGHSON, David Callum | Administrateur | 55 Gracechurch Street EC3V 0UF London | British | 62284790002 | ||||||
| MARTIN, Julia Helen | Administrateur | 79 Streathbourne Road SW17 8RA London | British | 84688790001 | ||||||
| MARTIN, Julia Helen | Administrateur | 79 Streathbourne Road SW17 8RA London | British | 84688790001 | ||||||
| MOULDER, Stuart Christopher | Administrateur | Uvongo House Blackmore Road Blackmore CM4 0QX Ingatestone Essex | England | British | 46329920001 | |||||
| PARDOE, Richard Grenville | Administrateur | Cherry Tree Cottage 17 West Avenue HP10 8AE Penn Buckinghamshire | England | British | 141544990001 | |||||
| SCOTT, Nicholas Peter | Administrateur | 7 Poplar Close Great Gransden SG19 3AX Sandy Bedfordshire | England | British | 108455130001 | |||||
| TAME, Russell | Administrateur | Orchard House 1a Mill Road CB21 5LT West Wratting Cambridgeshire | British | 117422530001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
HAWKDECIDE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Marine mortgage | Créé le 25 sept. 2006 Livré le 29 sept. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 64/64 shares in the ship "perfect ten" official no 912067 and in its appurtenances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Marine mortgage | Créé le 21 juin 2006 Livré le 24 juin 2006 | En cours | Montant garanti £92,000.00 and all other monies due or to become due | |
Brèves mentions X35 hull id no. Dk-XYA35037C606. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 02 juil. 2002 Livré le 16 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the turnstone estates limited and any other company which is a holding or subsidiary of turnstone estates limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights,titles,benefits and interests under the leases in respect of b & q valleybridge rd,clacton on sea. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of legal charge | Créé le 02 juil. 2002 Livré le 16 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the turnstone estates limited and any other company which is a holding or subsidiary of turnstone estates limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold property known as b & q valleybridge rd,clacton on sea ;ex 461132; all buildings,erections,fixtures,fittings,equipment,fixed plant and machinery thereon and all moneys deposited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 02 sept. 1996 Livré le 12 sept. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,037,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H land and buildings k/a red lion buildings 12 cock lane london and a floating charge over the undertaking property assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0