ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED

ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03235415
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o LEVEL 26
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital au 04 nov. 2015

    • Capital: GBP 0.01
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 032354150008 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 août 2015

    État du capital au 10 août 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mrs Mandy Rutter en tant qu'administrateur le 14 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Ashley Graham Woods en tant qu'administrateur le 26 juin 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Aram John Hoare en tant que directeur le 26 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    12 pagesAA

    Satisfaction de la charge 032354150005 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 032354150006 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 août 2014

    État du capital au 08 août 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Inscription de la charge 032354150007

    21 pagesMR01

    Inscription de la charge 032354150008

    22 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Keith Grehan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Conor Gerard Clinch en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 30 St. Mary Axe London EC3A 8EP United Kingdom* le 12 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Liesl Asaa en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Ashley Graham Woods en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de * 120 Leman Street London E1 8EU* le 05 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOODS, Ashley Graham
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    181091400001
    CLINCH, Conor Gerard
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    IrelandIrishAccountant188231340001
    RUTTER, Mandy
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    Administrateur
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    EnglandBritishFinance Director177638750001
    WOODS, Ashley Graham
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    Administrateur
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    EnglandAustralianSolicitor195520510001
    ASAA, Liesl
    The Gasworks
    Barrow Street
    Dublin 4
    59 William Bligh
    Ireland
    Secrétaire
    The Gasworks
    Barrow Street
    Dublin 4
    59 William Bligh
    Ireland
    IrishSolicitor136091870001
    FREEMAN, Robert Neil
    Asha
    12a Valkyrie Avenue
    CT5 4DJ Whitstable
    Kent
    Secrétaire
    Asha
    12a Valkyrie Avenue
    CT5 4DJ Whitstable
    Kent
    British122758450001
    LACEY, Stephen
    The Coach House
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    The Coach House
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant88368490002
    PLATT, Michael Anthony
    5 Cholmeley Court
    Southwood Lane
    N6 5TD London
    Secrétaire
    5 Cholmeley Court
    Southwood Lane
    N6 5TD London
    British79000230002
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Secrétaire désigné
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    BENSON, James Peter
    The White House
    Brockley Backwell
    BS48 3AU Bristol
    Administrateur
    The White House
    Brockley Backwell
    BS48 3AU Bristol
    United KingdomBritishFinance Director52756120001
    DAY, Peter Donal
    Flat 2
    14 Cottenham Park Road
    SW20 0RZ London
    Administrateur
    Flat 2
    14 Cottenham Park Road
    SW20 0RZ London
    BritishChief Executive16049470002
    FREEMAN, Robert Neil
    Eden Road
    Seasalter
    CT5 4AP Whitstable
    24a
    Kent
    Administrateur
    Eden Road
    Seasalter
    CT5 4AP Whitstable
    24a
    Kent
    EnglandBritishChief Executive122758450002
    GREHAN, Keith William
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    United KingdomIrishFinancial Consultant161598880001
    HARRISON, Steven Peter
    46 Kelmscott Road
    SW11 6QY London
    Administrateur
    46 Kelmscott Road
    SW11 6QY London
    EnglandBritishEngineer69272540002
    HOARE, Aram John
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Level 26
    St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    United Kingdom
    IrelandAustralianLawyer152785810001
    LACEY, Stephen
    The Coach House
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    The Coach House
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant88368490002
    WRIGHT, Paul Keith
    York Avenue
    SW14 7LQ London
    73
    Administrateur
    York Avenue
    SW14 7LQ London
    73
    United KingdomBritishChartered Accountant136485130001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Administrateur désigné
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    ROLFE & NOLAN INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2014
    Livré le 19 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch
    Transactions
    • 19 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2014
    Livré le 19 juin 2014
    En cours
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch
    Transactions
    • 19 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 mai 2013
    Livré le 03 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch
    Transactions
    • 03 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 22 mai 2013
    Livré le 03 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch
    Transactions
    • 03 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Amended and restated debenture
    Créé le 23 août 2007
    Livré le 31 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital land and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cit Capital Finance (UK) Limited (the Security Trustee)
    Transactions
    • 31 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 juin 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charges over all of the present and future assets, land, equipment, goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cit Finance (UK) Limited (the Security Trustee)
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 14 déc. 2004
    Livré le 17 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the companies to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Finance Parties
    Transactions
    • 17 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 janv. 2000
    Livré le 26 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0