ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéECD (COOKHAM WOOD) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03241233
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction
    • Enseignement secondaire technique et professionnel (85320) / Enseignement

    Où se situe ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Chris Burlton le 26 janv. 2018

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ à C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place Portwall Lane Bristol BS1 6NA le 15 juin 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 mai 2017

    LRESSP

    Modification des coordonnées du secrétaire Semperian Secretariat Services Limited le 19 mai 2017

    1 pagesCH04

    Cessation de la nomination de Alan Campbell Ritchie en tant que directeur le 31 mars 2017

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2016

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Paul Roger Cook en tant que directeur le 18 mai 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gawie Murray Nienaber en tant que directeur le 18 mai 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Parker en tant que directeur le 18 mai 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Vaishali Jagdish Patel en tant que directeur le 18 mai 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 août 2015

    État du capital au 24 août 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Roger Cook le 01 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Chris Burlton en tant qu'administrateur le 02 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Vaishali Jagdish Patel en tant qu'administrateur le 17 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    107624260005
    BURLTON, Chris
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish191923330001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Secrétaire
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BARLOW, Suzanne
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    Secrétaire
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    British49252810001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    British52429400001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Administrateur
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BANKS, Andrew David
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish164295230001
    BIRCH, Alan Edward
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish90700330001
    BIRCH, Alan Edward
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish90700330001
    BROWN, Matthew Charles
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Administrateur
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish181465860001
    BROWN, Stephen Richard
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    Administrateur
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    British15085940005
    COOK, Paul Roger
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Administrateur
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    UkBritish117120110001
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Administrateur
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Administrateur
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    ELLIOTT, Christopher
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish64082070001
    FARLEY, Graham
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    Administrateur
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    United KingdomBritish183764380001
    GILBEY, Hannah
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British78180430001
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Administrateur
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    HARROWER, James Arthur
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    Administrateur
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    British12257110001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Administrateur
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Administrateur
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    JONES, Stuart Nigel
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    British79744320001
    LAVERS, Michael John
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    Administrateur
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    EnglandBritish3090450001
    MALMBERG, Louis Joannes
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Administrateur
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Dutch45086130001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Administrateur
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    British678610003
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Administrateur
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Administrateur
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    MORGAN, David Keir Ewart
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Administrateur
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish106484320002
    MORRIS, Richard
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish159675380001
    NIENABER, Gawie Murray
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    Administrateur
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    EnglandBritish187146260001
    OSBORNE, Robert Charles
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    Administrateur
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    British68448420001
    PARKER, John
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    Administrateur
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    United KingdomEnglish182836610001
    PATEL, Vaishali Jagdish
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Administrateur
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    United KingdomBritish192721880001
    PELLARD, Brian
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33408310001

    ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 19 nov. 2004
    Livré le 24 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a cookham wood secure training centre cookham wood rochester kent.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transactions
    • 24 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 21 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental fixed charge
    Créé le 31 janv. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the equipment including all moneyspayable and the proceeds of any claims awards or judgements together with interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department (Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Whole or in Part and Whether at Law or in Equity)
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 31 janv. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sums payable by her majesty's principal secretary of state for the home department (the "authority") to the company pursuant to schedule u of an agreement (the "dcmf contract") dated 3RD march 1997 between the mortgagor and the authority for the design construction maintenance and operation of a secure training centre at medway kent.
    Personnes ayant droit
    • Carillion Construction Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge debenture
    Créé le 03 mars 1997
    Livré le 10 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any banks financing document
    Brèves mentions
    .Leasehold property known as cookham wood, rochester, kent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Bank Secured Creditors)
    Transactions
    • 10 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 21 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 mars 1997
    Livré le 10 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or connection with any banks financing document
    Brèves mentions
    All that leasehold property knoen as cookham wood secure training centre, cookham wood, rochester, kent.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Banks Secured Creditors)
    Transactions
    • 10 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 21 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of fixed charge
    Créé le 03 mars 1997
    Livré le 08 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligation of the company owed to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement dated 3RD march 1997 between the chargee and the company (as therein defined) ("the dcmf contract") to transfer title to the equipment (as therein defined) upon termination of the "dcmf contract" together with any damages payable by the company to the chargee by reason of a failure to comply with clause 17.2 of the "dcmf contract"
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest (present and future) to and in the equipment being all the property referred to in schedule b of the dcmf contract and all the plant machinery and other equipment referred to in schedule a of the dcmf contract by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department(Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Wholeor in Part and Whether at Law or in Equity)
    Transactions
    • 08 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mai 2017Commencement of winding up
    02 mai 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gilbert J Lemon
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    practitioner
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Richard Lewis
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    practitioner
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0