COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03245098 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Latham Nelson le 25 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 14 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Birch le 16 janv. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Lee Milner en tant que directeur le 12 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 11 pages | AA | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Sherard Secretariat Services Limited le 02 sept. 2019 | 1 pages | CH04 | ||
Modification des détails de Durley Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ à Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB le 02 sept. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 10 pages | AA | ||
Modification des détails de Durley Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 10 pages | AA | ||
Nomination de Mr Paul Birch en tant qu'administrateur le 12 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Administrateur | 142 Speke Road L19 2PH Liverpool The Matchworks England England | United Kingdom | British | 76116640004 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 36191090004 | |||||||||
| BIRCH, Paul | Secrétaire | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | British | 76116640002 | ||||||||||
| HEELEY, John Andrew | Secrétaire | 53 Bents Drive S11 9RN Sheffield | British | 44214630004 | ||||||||||
| STINTON, Jo Anne Marjorie | Secrétaire | 17 Pinewood Avenue TN14 5AE Sevenoaks Kent | British | 51007460003 | ||||||||||
| WILLIAMS, Mark | Secrétaire | 8 Manor Road RH2 9LB Reigate Surrey | British | 48724630001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BOWDEN, Peter Michael | Administrateur | 15 Wilmington Avenue BR6 9BJ Orpington Kent | British | 51008240001 | ||||||||||
| DAY, Stephen John | Administrateur | Becca House Becca Lane Aberford LS25 3BD Leeds | England | British | 59028300002 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 61515760002 | |||||||||
| FLOOD, John Joseph | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 73695830003 | |||||||||
| FOSTER, David Neil | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | England | British | 79227590003 | |||||||||
| FRASER, Ian Ellis | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||||||
| GAVAN, John Vincent | Administrateur | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | England | British | 36153790001 | |||||||||
| HEELEY, John Andrew | Administrateur | 53 Bents Drive S11 9RN Sheffield | England | British | 44214630004 | |||||||||
| JOYCE, Martin John | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | England | British | 72254420003 | |||||||||
| KIRKBY, Neil Robert Ernest | Administrateur | 5 Dashwood Close Grappenhall WA4 3JA Warrington Cheshire | England | British | 51438040006 | |||||||||
| MCGRORY, Jack | Administrateur | 12 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 96596920001 | |||||||||
| MCLAUGHLIN, Owen Gerard | Administrateur | Lancaster House Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancashire | United Kingdom | British | 17129800004 | |||||||||
| MILNER, Andrew Lee | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 133714170002 | |||||||||
| STICKLAND, Nigel Prior | Administrateur | 24 Osier Way High Beeches SM7 1LL Banstead Surrey | England | British | 13242280001 | |||||||||
| UNDERWOOD, Robin David | Administrateur | 40 Bramfield Road Clapham SW11 6RB London | British | 78388540002 | ||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durley Group Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 18 mai 2007 Livré le 31 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 juin 2001 Livré le 09 juin 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company (formerly known as cpi countrywide limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0