EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED

EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03246798
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Lodge Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Sarah Elizabeth Welsby en tant que directeur le 01 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 03 sept. 2016 avec mises à jour

    8 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré The Lodge Hospital Road Penpedairheol Hengoed CF82 8DG

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à The Lodge Hospital Road Penpedairheol Hengoed CF82 8DG

    1 pagesAD02

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2015

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2015

    État du capital au 09 sept. 2015

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2014

    1 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Gelligaer Court Hospital Road Pendpedairheol, Hengoed Caerphilly CF82 8DG à The Lodge Hospital Road Penpedairheol Hengoed Mid Glamorgan CF82 8DG le 06 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 sept. 2014

    État du capital au 06 sept. 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 sept. 2013

    État du capital au 29 sept. 2013

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2011

    4 pagesAA

    legacy

    11 pagesMG01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2010

    4 pagesAA

    legacy

    10 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Cynthia Anne Banks le 05 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stuart Albert Banks le 05 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BANKS, Stuart Albert
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    British8439770001
    BANKS, Cynthia Anne
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    WalesBritish8439760001
    BANKS, Stuart Albert
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    WalesBritish8439770001
    JOHNSON, Helen Louise
    Gelligaer Court
    Hospital Road
    CF82 8DG Penpedairheol
    The Lodge
    Caerphilly C.B.C.
    Great Britain
    Administrateur
    Gelligaer Court
    Hospital Road
    CF82 8DG Penpedairheol
    The Lodge
    Caerphilly C.B.C.
    Great Britain
    Great BritainBritish48136810006
    BANKS, Cynthia Anne
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    Gelligaer Court Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    Mid Glamorgan
    British8439760001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire désigné
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    HUGHES, Graham Aubrey
    2 Greenway Avenue
    Rumney
    CF3 8HQ Cardiff
    Secrétaire
    2 Greenway Avenue
    Rumney
    CF3 8HQ Cardiff
    British50025930001
    MATHIAS, Clive Stanley
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    Secrétaire
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    British90539780002
    HUGHES, Graham Aubrey
    2 Greenway Avenue
    Rumney
    CF3 8HQ Cardiff
    Administrateur
    2 Greenway Avenue
    Rumney
    CF3 8HQ Cardiff
    British50025930001
    JOHNSON, Helen Louise
    146 Corner Houses
    Heolgerrig
    CF48 1RH Merthyr Tydfil
    Administrateur
    146 Corner Houses
    Heolgerrig
    CF48 1RH Merthyr Tydfil
    British48136810005
    WELSBY, Sarah Elizabeth
    44 Hengoed Road
    Penpedairheol
    CF82 8BQ Hengoed
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    44 Hengoed Road
    Penpedairheol
    CF82 8BQ Hengoed
    Mid Glamorgan
    WalesBritish48136920001
    WELSBY, Sarah Elizabeth
    44 Hengoed Road
    Penpedairheol
    CF82 8BQ Hengoed
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    44 Hengoed Road
    Penpedairheol
    CF82 8BQ Hengoed
    Mid Glamorgan
    WalesBritish48136920001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Administrateur désigné
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Cynthia Anne Banks
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    06 avr. 2016
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Sarah Elizabeth Welsby
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    06 avr. 2016
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Wales
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Helen Johnson
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    06 avr. 2016
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Wales
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Stuart Albert Banks
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    06 avr. 2016
    Hospital Road
    Penpedairheol
    CF82 8DG Hengoed
    The Lodge
    Mid Glamorgan
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    EXCLUSIVE PROPERTY SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 mars 2012
    Livré le 22 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Bank)
    Transactions
    • 22 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 20 nov. 2010
    Livré le 30 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 42 and 44 dimond street, pembroke dock, t/no: wa 972841 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 2004
    Livré le 15 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 13 déc. 2004
    Livré le 15 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold beng 42 and 44 dimond street,pembroke dock,wa 972841. with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 mars 2004
    Livré le 26 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    £7,683.74 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Floating charge all undertaking and property present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Mr Stuart Albert Banks and Mrs Cynthia Anne Banks
    Transactions
    • 26 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 03 févr. 2003
    Livré le 04 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and express palletised storage limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 42 and 44 dimond street pembroke dock t/no WA972841. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 22 janv. 2003
    Livré le 04 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the traditional trading company limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property 42 and 44 dimond street pembroke dock title number WA972841. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0