ALPHABET LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALPHABET LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03250737
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALPHABET LIMITED ?

    • (5540) /

    Où se situe ALPHABET LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hillcroft
    Dartford Road
    DA4 9HX Horton Kirby
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALPHABET LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE DOZY DUCK LTD.17 sept. 199617 sept. 1996

    Quels sont les derniers comptes de ALPHABET LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ALPHABET LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2008

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2007

    3 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2006

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    3 pages395

    legacy

    3 pages395

    legacy

    9 pages395

    legacy

    1 pages403a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2005

    5 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2004

    5 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2003

    6 pagesAA

    legacy

    9 pages363s

    legacy

    7 pages395

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Qui sont les dirigeants de ALPHABET LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCKINNON CLARK, Nigel
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    British82806600001
    DRAPER, Mark James
    120 Station Road
    TW12 2AP Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    120 Station Road
    TW12 2AP Hampton
    Middlesex
    British82806640003
    MCKINNON CLARK, Nigel
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Grange Coach House
    Aylesbury Road
    HP22 6JQ Wendover
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82806600001
    BIERER, Gideon Itamar David Jodeph
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    Secrétaire
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    British60921420001
    CARNE, Charles Nicholas
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    Secrétaire
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    British30651520002
    HOAD, Francis Alister Knox
    93a Albert Street
    NW1 7LX London
    Secrétaire
    93a Albert Street
    NW1 7LX London
    Australian51041550001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Secrétaire désigné
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BARROW, Paul Achilles St Clair
    9 Hollywood Mews
    Chelsea
    SW10 9HU London
    Administrateur
    9 Hollywood Mews
    Chelsea
    SW10 9HU London
    United KingdomBritish51162560001
    BIERER, Gideon Itamar David Jodeph
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    Administrateur
    200 E 16th Street
    Apartment 15h
    New York
    Ny 10003
    America
    British60921420001
    BOULTON, Matthew Gresford
    19 Allestree Road
    SW6 6AD London
    Administrateur
    19 Allestree Road
    SW6 6AD London
    British48810030002
    CARNE, Charles Nicholas
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    Administrateur
    49 Windmill Road
    W4 1RN London
    United KingdomBritish30651520002
    COURT, Philippe
    Flat 6
    36-42 Clerkenwell Road, Clerkenwell
    EC1M 5PS London
    Administrateur
    Flat 6
    36-42 Clerkenwell Road, Clerkenwell
    EC1M 5PS London
    British108361790001
    MAILLARD, Andrew Clement
    10a Mozart Street
    W10 4LA London
    Administrateur
    10a Mozart Street
    W10 4LA London
    British58698360001
    SURL, Mark Edwin
    286 Upland Road
    SE22 0DP London
    Administrateur
    286 Upland Road
    SE22 0DP London
    British64367620002
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Administrateur désigné
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001

    ALPHABET LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 09 juin 2006
    Livré le 19 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or alphabet bars limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H amber bar 6 poland street london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 09 juin 2006
    Livré le 19 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or alphabet bars limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H alphabet bar 61-63 beak street london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 mai 2006
    Livré le 26 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 06 oct. 2003
    Livré le 07 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 07 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 oct. 2000
    Livré le 18 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property known as 6 poland st,london; NGL789728. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 09 oct. 2000
    Livré le 17 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 oct. 2000
    Livré le 17 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property known as 61-63 beak st,london. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 19 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    £42,300.00 due from the company to the chargee under the lease of even date
    Brèves mentions
    £42,300 pursuant to this deed.
    Personnes ayant droit
    • Mddt Nominees S.A.and Wilfe Nominees Limited
    Transactions
    • 19 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 22 janv. 1997
    Livré le 08 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £32,312.50 and all other sums due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Rent deposit in the sum of £32,312.50.
    Personnes ayant droit
    • Capitalstart Limited
    Transactions
    • 08 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0