WREN EXTRA CARE GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWREN EXTRA CARE GROUP PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03253045
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WREN EXTRA CARE GROUP PLC ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe WREN EXTRA CARE GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    The Cade Barn
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    East Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WREN EXTRA CARE GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WREN HOMES GROUP PLC09 nov. 200109 nov. 2001
    SARDIS INTERNATIONAL PLC21 oct. 199621 oct. 1996
    GROWTHVOTE LIMITED20 sept. 199620 sept. 1996

    Quels sont les derniers comptes de WREN EXTRA CARE GROUP PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WREN EXTRA CARE GROUP PLC ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WREN EXTRA CARE GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Dominic Wainford en tant que directeur

    2 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2012 sans liste des membres

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 oct. 2012

    État du capital au 18 oct. 2012

    • Capital: GBP 5,242,238.7
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2011

    46 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2010

    46 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2011 avec liste étendue des actionnaires

    17 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Montford Victor Butterfield le 01 nov. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian Kenneth Clark Nathan le 01 nov. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Self le 01 nov. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dominic Mark Joseph Wainford le 01 nov. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr James Montford Victor Butterfield le 01 nov. 2010

    3 pagesCH03

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Michael O'donnell en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian Kenneth Clark Nathan le 11 févr. 2011

    3 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 juil. 2010 au 31 déc. 2010

    3 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de * Suite 4 Oaks House 12-22 West Street Epsom KT18 7RG* le 05 janv. 2011

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    71 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Paul Treadway en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de WREN EXTRA CARE GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUTTERFIELD, James Montford Victor
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    Secrétaire
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    British4122400001
    BUTTERFIELD, James Montford Victor
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    Administrateur
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director/Economist4122400001
    NATHAN, Brian Kenneth Clark
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    England
    Administrateur
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    England
    United KingdomBritishCompany Director1709250005
    SELF, Philip
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    England
    Administrateur
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    England
    EnglandBritishCompany Difrector/Chartered Accountant96302430001
    EVANS, Andrew Mark
    17 Eastbrook Close
    New Hall
    B76 1DD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    17 Eastbrook Close
    New Hall
    B76 1DD Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54483530001
    GILLIS, Peter Alan Cecil
    17 Kingsley Way
    N2 0EH London
    Secrétaire
    17 Kingsley Way
    N2 0EH London
    BritishSolicitor21968100001
    RUDGE, Anthony Alexander De Nouaille
    The Old Bakery
    Epwell
    OX15 6LA Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    The Old Bakery
    Epwell
    OX15 6LA Banbury
    Oxfordshire
    British76248480001
    ENDLEY, Robert
    109 Chesterfield Road
    St Andrews
    BS6 5DS Bristol
    Administrateur
    109 Chesterfield Road
    St Andrews
    BS6 5DS Bristol
    BritishComposer66053360001
    GILES, Peter Mark Hedges
    16 Raleigh Road
    Southville
    BS3 1QR Bristol
    Avon
    Administrateur
    16 Raleigh Road
    Southville
    BS3 1QR Bristol
    Avon
    BritishComposer70793310002
    GILLIS, Peter Alan Cecil
    17 Kingsley Way
    N2 0EH London
    Administrateur
    17 Kingsley Way
    N2 0EH London
    BritishSolicitor21968100001
    HAYES, John
    Whitegates 17 Southlea Road
    Datchet
    SL3 9BY Slough
    Berkshire
    Administrateur
    Whitegates 17 Southlea Road
    Datchet
    SL3 9BY Slough
    Berkshire
    BritishDirector3767650001
    HUNT, James Christopher
    Bridge Cottage
    Mill Lane Blockley
    GL56 9HT Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Administrateur
    Bridge Cottage
    Mill Lane Blockley
    GL56 9HT Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    United KingdomBritishSolicitor76888410001
    MARDON, Nial Alexander
    61 Allington Road
    BS3 1PT Bristol
    Administrateur
    61 Allington Road
    BS3 1PT Bristol
    BritishComputer Programmer50121970001
    O'DONNELL, Michael Robert Gerard
    West Street
    KT18 7RG Epsom
    Oaks House 12-22
    Surrey
    Administrateur
    West Street
    KT18 7RG Epsom
    Oaks House 12-22
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant69389250001
    REED, Bradley
    Hillside Cottages
    GL6 8LT Lynch
    Glouestershire
    Administrateur
    Hillside Cottages
    GL6 8LT Lynch
    Glouestershire
    CanadianDirector101240390001
    SLADE, David Nathaniel
    Victor Palace
    31 Avenue Grand Bretagne
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    Administrateur
    Victor Palace
    31 Avenue Grand Bretagne
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    BritishProperty Investor39210570005
    SLADE, David Nathaniel
    59 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PT London
    Administrateur
    59 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PT London
    BritishConsultant39210570002
    SONNENTHAL, Michael
    4 Frognal Rise
    Frognal Hampstead
    NW3 6RD London
    Administrateur
    4 Frognal Rise
    Frognal Hampstead
    NW3 6RD London
    United KingdomBritishConsultant34430250004
    TREADWAY, Paul Arthur
    Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    15
    Surrey
    Administrateur
    Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    15
    Surrey
    BritishDirector79184950002
    WAINFORD, Dominic Mark Joseph
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    England
    Administrateur
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    The Cade Barn
    East Sussex
    England
    EnglandBritishDirector50652240003
    WEST, Peter James
    31 Mayes Close
    CR6 9LB Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    31 Mayes Close
    CR6 9LB Warlingham
    Surrey
    BritishDirector39791850002

    WREN EXTRA CARE GROUP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 2005
    Livré le 09 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a 55 carshalton road sutton surrey t/n SGL203619. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 mars 2005
    Livré le 12 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 sept. 2003
    Livré le 23 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 janv. 2003
    Livré le 07 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    55 carshalton road sutton surrey SM1 4LH. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WREN EXTRA CARE GROUP PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 janv. 2003Date of completion or termination of CVA
    16 janv. 2001Date of meeting to approve CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William Antony Batty
    New House
    Suite 24
    EC1N 8JY 67-68 Hatton Garden
    London
    practitioner
    New House
    Suite 24
    EC1N 8JY 67-68 Hatton Garden
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0