DLX INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDLX INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03253075
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DLX INVESTMENTS LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe DLX INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DLX INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CORNGREEN LIMITED20 sept. 199620 sept. 1996

    Quels sont les derniers comptes de DLX INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour DLX INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 juin 2010

    5 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 déc. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 juin 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 déc. 2008

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes établis au 31 mars 2006

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    15 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de DLX INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JOHNSON, Jean Jean Marie
    435 16th Avenue N.E.
    St Petersburg
    Florida 33704
    Usa
    Secrétaire
    435 16th Avenue N.E.
    St Petersburg
    Florida 33704
    Usa
    British125670490001
    QUIBELL, Edward Keith
    2600 Brookside Drive
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30076
    Usa
    Administrateur
    2600 Brookside Drive
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30076
    Usa
    AmericanCfo117070810001
    DUMOND, Paul George
    68 Philbeach Gardens
    SW5 9EE London
    Secrétaire
    68 Philbeach Gardens
    SW5 9EE London
    BritishCompany Secretary266200001
    KRITZINGER, Louis Francois
    Flat 6 52 Credition Hill
    West Hampstead
    NW6 1HR London
    Secrétaire
    Flat 6 52 Credition Hill
    West Hampstead
    NW6 1HR London
    British,South AfricanFinance Director118680170001
    TRICKETT, Deborah Joan
    Flat B 1 Sydenham Park
    SE26 4EE London
    Secrétaire
    Flat B 1 Sydenham Park
    SE26 4EE London
    British69302930001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    DUMOND, Paul George
    68 Philbeach Gardens
    SW5 9EE London
    Administrateur
    68 Philbeach Gardens
    SW5 9EE London
    United KingdomBritishChartered Accountant266200001
    KENDALL, David William
    41 Albion Street
    W2 2AU London
    Administrateur
    41 Albion Street
    W2 2AU London
    United KingdomBritishDirector9207490001
    KRITZINGER, Louis Francois
    Flat 6 52 Credition Hill
    West Hampstead
    NW6 1HR London
    Administrateur
    Flat 6 52 Credition Hill
    West Hampstead
    NW6 1HR London
    United KingdomBritish,South AfricanFinance Director118680170001
    NELSEN, Keith
    2603 Sanders Drive
    FOREIGN Tampa
    Florida 33611
    Usa
    Administrateur
    2603 Sanders Drive
    FOREIGN Tampa
    Florida 33611
    Usa
    Us CitizenLawyer77429440001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STARK, Jason Alexander
    36 Grove Lane
    KT1 2ST Kingston
    Surrey
    Administrateur
    36 Grove Lane
    KT1 2ST Kingston
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant80079940001
    TRICKETT, Deborah Joan
    Flat B 1 Sydenham Park
    SE26 4EE London
    Administrateur
    Flat B 1 Sydenham Park
    SE26 4EE London
    BritishCompany Secretary69302930001
    VAUGHAN-LEE, Mark Andrew
    Ashcombe Farm Cottage
    Tollard Royal
    SP5 5QG Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Ashcombe Farm Cottage
    Tollard Royal
    SP5 5QG Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director65097930002
    WILLSEA, Robert
    32 Settrington Road
    SW6 3BA London
    Administrateur
    32 Settrington Road
    SW6 3BA London
    BritishCompany Director53863500001

    DLX INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A security agreement
    Créé le 02 oct. 2001
    Livré le 13 oct. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party under each loan document to which such obligor is a party except for any obligation which if it were so included would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America N.a as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 13 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    A pledge of shares by the chargor, ncnr oil & gas limited, duskhaven limited and danka international limited in favour of bank of america N.A. (the "agent") (as agent and trustee for itself and each of the banks)
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 07 sept. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the all or any of the companies to the agent and/or the banks under any of the documents and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    121 ordinary shares and 364 b ordinary shares owned in danka holdings sarl and all dividends intersts bonuses option rights etc in relation to the shares.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America N.A.
    Transactions
    • 07 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Pledge of shares
    Créé le 09 mai 1997
    Livré le 28 mai 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any of the loan documents the guarantee given by danka holdings sarl and any other agreement supplemeting or amending the loan documents (each such capitalised term having the same meaning as in the credit agreement dated 5TH december 1996)
    Brèves mentions
    (600) b ordinary shares of danka holdings sarl including all dividends interest bonus option rights etc in respect therreof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationsbank N.A.(As Lender and as Agent for the Banks (as Defined in the Credit Agrement))
    Transactions
    • 28 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Pledge over shares
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 06 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All advances debts liabilities obligations covenants and duties arising under any loan document due or to become due from the company to the chargee and all international swing line obligations and obligations owing to banks in respect of international swing line participations (each such capitalised term having the same meaning as in the credit agreement dated 5 december 1996)
    Brèves mentions
    Fixed charge over the shares (as defined) together with all allotments acretations benefits and advantages whatsoever including all stocks shares securities and all dividends moneys rights and property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationsbank N.A.(As Lender and Agent for the Banks (as Defined in the Credit Agreement))
    Transactions
    • 06 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Pledge over shares
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 06 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All advances debts liabilities obligations covenants and duties arising under any loan document due or to become due from the company to the chargee and all international swing line obligations and obligations owing to banks in respect of international swing line participations (each such capitalised term having the same meaning as in the credit agreement dated 5 december 1996)
    Brèves mentions
    Fixed charge over the shares (as defined) together with all allotments acretations benefits and advantages whatsoever including all stocks shares securities and all dividends moneys rights and property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationsbank N.A.
    Transactions
    • 06 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over shares
    Créé le 18 déc. 1996
    Livré le 06 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All advances debts liabilities obligations covenants and duties arising under any loan document and all international swing line obligations and obligations owing to banks in respect of international swing line participations (each such capitalised term having the same meaning as in the credit agreement dated 5 december 1996) and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    First fixed charge the shares (as defined) together with all alotments acretions benefits and advantages whatsoever including all stocks shares and securities and all dividends moneys rights and property in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationsbank N.A.(As Agent for the Banks (as Defined in the Credit Agreement))
    Transactions
    • 06 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)

    DLX INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 déc. 2007Commencement of winding up
    09 oct. 2010Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0