SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED

SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHERMAN COOPER MARKETING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03254173
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED ?

    • Commerce de gros de vêtements et de chaussures (46420) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAYLEIGH 15 LTD.24 sept. 199624 sept. 1996

    Quels sont les derniers comptes de SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    22 pagesLIQ14
    YCDGGVBS

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juin 2023

    22 pagesLIQ03
    YC97QRN7

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juin 2022

    22 pagesLIQ03
    YB8L95GG

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    5 pagesLIQ10
    YB3WH6AZ

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600
    YB3WH417

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juin 2021

    22 pagesLIQ03
    YA9LCG7U

    Changement d'adresse du siège social de Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB à Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU le 11 nov. 2020

    2 pagesAD01
    A9H9BMLU

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juin 2020

    22 pagesLIQ03
    A9AMFFK0

    Changement d'adresse du siège social de The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB à Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB le 17 mars 2020

    2 pagesAD01
    A90RS482

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juin 2019

    22 pagesLIQ03
    A89ZZIX5

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06
    A7LBYISJ

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juin 2018

    22 pagesLIQ03
    A7BNNKCW

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juin 2017

    21 pagesLIQ03
    A6DVAROW

    Changement d'adresse du siège social de 2 Eyre Street Hill Clerkenwell London EC1R 5ET à The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB le 07 oct. 2016

    2 pagesAD01
    A5GJX7YR

    Changement d'adresse du siège social de 2 Eyre Street Hill Clerkenwell London EC1R 5ET à 2 Eyre Street Hill Clerkenwell London EC1R 5ET le 30 juin 2016

    2 pagesAD01
    A59F3NQ3

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20
    A59F3NPV

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    9 pages600
    A59F3NQB

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 16 juin 2016

    LRESEX

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2016

    État du capital au 12 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X4YF4P77

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2015

    3 pagesAA
    J4MDDWYH

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04
    A4HLFK83

    Inscription de la charge 032541730005, créée le 17 juil. 2015

    78 pagesMR01
    A4C883CW

    Nomination de Mr Rafael Klotz en tant qu'administrateur le 17 juil. 2015

    2 pagesAP01
    X4C1HN9V

    Nomination de Mr Malcolm Maclennan Macaulay en tant qu'administrateur le 17 juil. 2015

    2 pagesAP01
    X4C1HPBT

    Qui sont les dirigeants de SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KLOTZ, Rafael
    13 Hanover Square
    W1S 1HN London
    Gordon Brothers, 3rd Floor
    England
    Administrateur
    13 Hanover Square
    W1S 1HN London
    Gordon Brothers, 3rd Floor
    England
    United StatesAmericanSenior Managing Director199514070001
    MACAULAY, Malcolm Maclennan
    Hanover Square
    W1S 1HN London
    Gordon Brothers Europe, 3rd Floor
    England
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1HN London
    Gordon Brothers Europe, 3rd Floor
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer91597360001
    COOK, Elizabeth Lucy Graham
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    Secrétaire
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    188437490001
    GAGE, Lee Stafford
    Eyre St Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    2
    Secrétaire
    Eyre St Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    2
    British146788850001
    LAMONT, Michael
    26 Balgonie Avenue
    PA2 9LP Paisley
    Renfrewshire
    Secrétaire
    26 Balgonie Avenue
    PA2 9LP Paisley
    Renfrewshire
    BritishFinance Director49721170001
    MILLS, Thomas Hamilton
    11 Mossbrook Road
    Moneyrea
    BT23 6BX Newtownards
    County Down
    Secrétaire
    11 Mossbrook Road
    Moneyrea
    BT23 6BX Newtownards
    County Down
    BritishDirector145863590001
    REID, Allan Christopher
    37 Kirklands Crescent
    Bothwell
    G71 8HJ Glasgow
    South Lanarkshire
    Secrétaire
    37 Kirklands Crescent
    Bothwell
    G71 8HJ Glasgow
    South Lanarkshire
    British83866820001
    SATER, Roisen Mark
    13 Earls Terrace
    W8 6LP London
    Secrétaire
    13 Earls Terrace
    W8 6LP London
    BritishCompany Director12462670003
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Secrétaire
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    UK COMPANY SECRETARIES LIMITED
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    Secrétaire désigné
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    900013390001
    BRANNAN, Robert
    13 Carlingnose Way
    North Queensferry
    KY11 1EU Inverkeithing
    Fife
    Administrateur
    13 Carlingnose Way
    North Queensferry
    KY11 1EU Inverkeithing
    Fife
    United KingdomBritishDirector64147580002
    CHODA, Jogesh
    9 Garland Hill
    BT8 6YL Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Administrateur
    9 Garland Hill
    BT8 6YL Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    United KingdomBritishChartered Accountant121436490001
    CHUBB III, Thomas Caldecott
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    Administrateur
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    UsaAmericanChief Executive99103590003
    DUNSMUIR, Lindsay Allan
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    Administrateur
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    EnglandBritishFinance Director82310450002
    FOWLER, Paul Tony
    Amerden Lakes
    Amerden Lane
    SL6 0EL Taplow
    No 2
    Berkshire
    Administrateur
    Amerden Lakes
    Amerden Lane
    SL6 0EL Taplow
    No 2
    Berkshire
    UkBritishAccountant152975090001
    GRAY, Miles Herbert
    Merrywind
    Stevens Lane, Claygate
    KT10 0TJ Esher
    Surrey
    Administrateur
    Merrywind
    Stevens Lane, Claygate
    KT10 0TJ Esher
    Surrey
    United KingdomBritishDirector145148080001
    LAMONT, Michael
    20 South Avenue
    PA2 7SP Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    20 South Avenue
    PA2 7SP Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritishFinance Director49721170002
    LAWLEY, Peter Schofield
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    Administrateur
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    United KingdomBritishChief Commercial Officer177440680001
    MAIDMENT, Mark
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    Administrateur
    2 Eyre Street Hill
    Clerkenwell
    EC1R 5ET London
    EnglandBritishChief Executive179126060001
    MILLS, Thomas Hamilton
    11 Mossbrook Road
    Moneyrea
    BT23 6BX Newtownards
    County Down
    Administrateur
    11 Mossbrook Road
    Moneyrea
    BT23 6BX Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritishDirector145863590001
    PHILIPPOU, Panicko Petros
    Eyre Street Hill
    EC1R 5ET London
    2
    Administrateur
    Eyre Street Hill
    EC1R 5ET London
    2
    EnglandBritishNone186730110001
    SATER, Roisen Mark
    13 Earls Terrace
    W8 6LP London
    Administrateur
    13 Earls Terrace
    W8 6LP London
    BritishCompany Director12462670003
    WALKER, William Samuel
    17 Craigboy Road
    BT21 0LP Donaghadee
    Administrateur
    17 Craigboy Road
    BT21 0LP Donaghadee
    Northern IrelandBritishDirector145504680001
    UK INCORPORATIONS LIMITED
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    Administrateur désigné
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    900013380001

    SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 juil. 2015
    Livré le 23 juil. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ben Sherman UK Acquisition Limited
    Transactions
    • 23 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 août 2000
    Livré le 30 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 août 2000
    Livré le 29 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities due or to become due by the company to the chargee or any of the investors (as defined in the charge) pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date with the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined in the Debenture)
    Transactions
    • 29 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mai 1997
    Livré le 17 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SHERMAN COOPER MARKETING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 janv. 2024Due to be dissolved on
    16 juin 2016Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Clare Kennedy
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Fraser James Gray
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    practitioner
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0