TRAMTRACK LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRAMTRACK LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03255005
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRAMTRACK LEASING LIMITED ?

    • (7121) /

    Où se situe TRAMTRACK LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Windsor House 42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRAMTRACK LEASING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHECKDANCE LIMITED26 sept. 199626 sept. 1996

    Quels sont les derniers comptes de TRAMTRACK LEASING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour TRAMTRACK LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Ian Brown en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 sept. 2010

    État du capital au 27 sept. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Ellen Howard le 01 sept. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Phillip George Hewitt le 01 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stuart Ian Munro le 01 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Howard Geoffrey Smith le 01 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Hughes Brown le 01 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Arthur Brown le 01 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Howard Ernest Carter le 01 sept. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jeffrey Pipe en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Arthur Brown le 17 avr. 2009

    3 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Timothy Powell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    17 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    15 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de TRAMTRACK LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARTER, Howard Ernest
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Secrétaire
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    British115261680001
    HOWARD, Ellen
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Secrétaire
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Other127591160001
    BROWN, Martin Hughes
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Administrateur
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritishDirector Of Health Safety And Environment86884970001
    HEWITT, Phillip George
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Administrateur
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritishHead Of London Trams131929690001
    MUNRO, Stuart Ian
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Administrateur
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritishDirector132345110001
    SMITH, Howard Geoffrey
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Administrateur
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    United KingdomBritishChief Operating Officer London Rail73999900002
    HARDING, Roger William
    Sunmead Cottage
    Green Street
    TW16 6QL Sunbury
    Secrétaire
    Sunmead Cottage
    Green Street
    TW16 6QL Sunbury
    BritishAccountant71123100003
    MORRIS, Anthony
    115a Burnt Ash Road
    Lee
    SE12 8RA London
    Secrétaire
    115a Burnt Ash Road
    Lee
    SE12 8RA London
    New Zealand63637740001
    PIPE, Jeffrey Henderson
    51 Cape Road
    CV34 5AA Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    51 Cape Road
    CV34 5AA Warwick
    Warwickshire
    British84554930001
    STOREY, John Anthony
    2 Silverbirch Drive
    Lacey Green
    HP27 0QF Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    2 Silverbirch Drive
    Lacey Green
    HP27 0QF Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishAccountant10426990001
    THORNTON, Jeffrey Michael
    49 Clermiston Road
    EH12 6XD Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    49 Clermiston Road
    EH12 6XD Edinburgh
    Midlothian
    BritishBanker19241770001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENNETT, Ralph William James
    Clonlea Field End Lane
    Holmbridge
    HD9 2NH Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Clonlea Field End Lane
    Holmbridge
    HD9 2NH Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director77285530001
    BROWN, Ian Arthur
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Administrateur
    Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritishManaging Director London Rail68292050002
    CAWTHORNE, David Alwyn
    21 Park Road
    RH8 0AN Oxted
    Surrey
    Administrateur
    21 Park Road
    RH8 0AN Oxted
    Surrey
    BritishCompany Director12217320001
    CHEVIS, Nicholas Keith
    Bramblewood 44 Church Road
    Wanborough
    SN4 0BZ Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Bramblewood 44 Church Road
    Wanborough
    SN4 0BZ Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishAccountant52041130003
    CHRISTIE, Vincent William
    Penbury Burtons Lane
    HP8 4BB Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Penbury Burtons Lane
    HP8 4BB Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishCivil Engineer10883860001
    CLARKE, Colin James
    Woodside Cottage Woodlands Lane
    Quarndon
    DE22 5JU Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Woodside Cottage Woodlands Lane
    Quarndon
    DE22 5JU Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritishProject Manager50604720001
    COLLARD, Michael John
    Birds Oak
    Leatherhead Road
    KT22 0JJ Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Birds Oak
    Leatherhead Road
    KT22 0JJ Oxshott
    Surrey
    BritishCivil Engineer49634040001
    COLLARD, Michael John
    Birds Oak
    Leatherhead Road
    KT22 0JJ Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Birds Oak
    Leatherhead Road
    KT22 0JJ Oxshott
    Surrey
    BritishEngineer49634040001
    COTTRELL, Keith
    51 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Chelsfield Park
    Kent
    Administrateur
    51 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Chelsfield Park
    Kent
    EnglandBritishInvestment Manager88691090003
    COWEN, Brendon Raymond
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant1234020001
    DAVISON, Paul Graham
    8 Swallow Craig
    Dalgety Bay
    KY11 9YR Fife
    Administrateur
    8 Swallow Craig
    Dalgety Bay
    KY11 9YR Fife
    United KingdomBritishManaging Director40733700001
    DOREY, Robert Frank
    9 Laburnum Gardens
    Shirley Oaks Village
    CR0 8XY Croydon
    Surrey
    Administrateur
    9 Laburnum Gardens
    Shirley Oaks Village
    CR0 8XY Croydon
    Surrey
    BritishCompany Director16433040002
    DUNCOMBE, Kenneth James
    3 Glendale Park
    Hitches Lane
    GU13 8JL Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    3 Glendale Park
    Hitches Lane
    GU13 8JL Fleet
    Hampshire
    BritishCo Director1386880001
    GEARON, Michael William
    Gorse Cottage Chuck Hatch Lane
    Colemans Hatch
    TN7 4EN Hartfield
    East Sussex
    Administrateur
    Gorse Cottage Chuck Hatch Lane
    Colemans Hatch
    TN7 4EN Hartfield
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director116425730001
    HENDY, Peter Gerard, Sir
    4 Cambridge Place
    BA2 6AB Bath
    Administrateur
    4 Cambridge Place
    BA2 6AB Bath
    EnglandBritishCompany Director62384480001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    KENDALL, Ian William
    16 Hillview Road
    Cults
    AB15 9HB Aberdeen
    Administrateur
    16 Hillview Road
    Cults
    AB15 9HB Aberdeen
    BritishManagement Consultant78207390006
    KENDALL, Ian William
    88 Addiscombe Road
    CR0 5PP Croydon
    Surrey
    Administrateur
    88 Addiscombe Road
    CR0 5PP Croydon
    Surrey
    AustralianCompany Director78207390004
    KING, Edmund Alec
    Spindlewood
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    Administrateur
    Spindlewood
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    BritishCivil Engineer13705700001
    LENOX CONYNGHAM, Charles Denis
    Yew Tree House
    Walkhurst Road
    TN17 4DR Benenden
    Kent
    Administrateur
    Yew Tree House
    Walkhurst Road
    TN17 4DR Benenden
    Kent
    EnglandBritishDirector96903010001
    MANDER, Simon Vivian
    127 Oyster Wharf
    18 Lombard Road, Battersea
    SW11 3RT London
    Administrateur
    127 Oyster Wharf
    18 Lombard Road, Battersea
    SW11 3RT London
    EnglandBritishAccountant169202990001
    MCALPINE, William Hepburn, Sir
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Administrateur
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    United KingdomBritishCivil Engineering And Building267620004
    MCCORMACK, Gerard Joseph
    16 Rectory Road
    RG40 1DH Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    16 Rectory Road
    RG40 1DH Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director93405490001

    TRAMTRACK LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 nov. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or tramtrack croydon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The real property being all estates and other interests in f/h, l/h and other immovable property, all group shares, the tangible movable property, all rights and claims, all letters patents trademarks etc, all goodwill, and all contracts and policies of insurance, book and other debts, interest in all stocks, shares together with all dividends, uncalled capital, floating charge over the undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Venture Leasing Limited
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral accounts security assignment
    Créé le 25 nov. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or tramtrack croydon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest in and to each of the lessor collateral accounts, the deposits, all other rights and benefits accruing to or arising in connection with the lessor collateral accounts and the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Venture Leasing Limited
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 1996
    Livré le 10 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and tramtrack croydon limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement and the finance documents referred to therein
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 10 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 1996
    Livré le 09 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and tramtrack croydon limited to the chargee (as security agent and trustee for the finance parties and the hedging banks (the "security agent")) on any account whatsoever under the terms of the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Dai-Ichi Kangyo Bank Limited
    Transactions
    • 09 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0