MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03259295
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ?

    • Autres activités d'édition de logiciels (58290) / Information et communication

    Où se situe MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL (CIS) LIMITED24 déc. 199624 déc. 1996
    ENGAGEBEAM LIMITED04 oct. 199604 oct. 1996

    Quels sont les derniers comptes de MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC05

    État du capital après une attribution d'actions au 31 mai 2017

    • Capital: GBP 2,845,447.00
    8 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    31 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Restriction on auth share cap is revoked and deleted 31/05/2017
    RES13

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Johannes Jacobus Olivier le 01 déc. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mai 2016

    13 pagesAA

    legacy

    60 pagesPARENT_ACC

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Nomination de Thomas Edward Kilroy en tant qu'administrateur le 21 mars 2016

    2 pagesAP01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mai 2015

    10 pagesAA

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    60 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 oct. 2015

    État du capital au 02 oct. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Johannes Jacobus Olivier en tant qu'administrateur le 20 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul Woodward en tant que directeur le 20 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 oct. 2014

    État du capital au 10 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Andrew Paul Woodward en tant qu'administrateur le 05 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sanjay Patel en tant que directeur le 28 août 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    KILROY, Thomas Edward
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    EnglandBritish166580200001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandSouth African199516920002
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    Secrétaire
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    146638030001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secrétaire
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07036299
    170449330001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DARBY, Andrew Hamish
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    9a Oatlands Chase
    KT13 9RF Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish114800800001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    Administrateur
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Administrateur
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WHITE, Andrew Ian
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    Administrateur
    Hillcott
    Perrotts Brook
    GL7 7BN Cirencester
    Glos
    United KingdomBritish93602410001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Administrateur
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1752099
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Créé le 29 juil. 2003
    Livré le 12 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Créé le 23 oct. 2002
    Livré le 13 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Créé le 09 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0