QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03260375
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Asticus Building 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HUDSON HOMES LIMITED08 oct. 199608 oct. 1996

    Quels sont les derniers comptes de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2015

    État du capital au 01 oct. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 20 juil. 2015

    1 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP à Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD le 05 août 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Jonathan David Farkas en tant qu'administrateur le 27 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mathieu Streiff en tant que directeur le 27 janv. 2015

    1 pagesTM01

    legacy

    28 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 sept. 2014

    État du capital au 18 sept. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mathieu Streiff le 31 mars 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 31 mars 2014

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de * Sanne Group 1 Berkeley Street London W1J 8DJ United Kingdom* le 07 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2014 au 31 déc. 2013

    3 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 oct. 2013

    État du capital au 07 oct. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Qui sont les dirigeants de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Secrétaire
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    Administrateur
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    LuxembourgAmerican193539990001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    British155548170001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    CO FORM (SECRETARIES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Secrétaire désigné
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001870001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish119804090001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish155548170001
    SAUNDERS, Peter Michael, Cllr
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish65642810001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    Administrateur
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United StatesAmerican200529310001
    TRANTER, Wilfred
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    Administrateur
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    British18193010002
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish133383410003
    CO FORM (NOMINEES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Administrateur désigné
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001860001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    06 avr. 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04258255
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 06 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 06 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 nov. 2007
    Livré le 27 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H miranda house high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT139689. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H the old presbytery high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT131191. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 03 nov. 1999
    Livré le 24 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as the old presbytery 77 high street, wootton bassett wilts title number WT131191. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 1997
    Livré le 19 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a miranda house nursing home high street wootton bassett t/no: WT139689.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 03 avr. 1997
    Livré le 19 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0