AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03260477 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | 305 Bridgewater Place Birchwood Park WA3 6XF Warrington United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2024 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 29 sept. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 oct. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 22 oct. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 oct. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Loren Michael Jones en tant qu'administrateur le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John White en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 305 305 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XF United Kingdom à 305 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XF le 11 nov. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 305 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XG United Kingdom à 305 305 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XF le 11 nov. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Jacobs Clean Energy Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed jacobs clean energy international LIMITED\certificate issued on 30/09/24 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Cottons Centre Cottons Lane London SE1 2QG United Kingdom à 305 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XG le 23 sept. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 29 sept. 2023 | 23 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Roberts en tant que secrétaire le 01 juin 2024 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Joshua David Prentice en tant que secrétaire le 01 juin 2024 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Geoffrey Roberts en tant que secrétaire le 21 août 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rhona Mary Holman en tant que secrétaire le 21 août 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2022 | 24 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Rhona Mary Holman en tant que secrétaire le 10 févr. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tejender Singh Chaudhary en tant que secrétaire le 10 févr. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 01 oct. 2021 | 24 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 02 oct. 2020 | 24 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 25 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de Jacobs Clean Energy Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 nov. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Nomination de Mr Roy Barrie Carter en tant qu'administrateur le 30 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRENTICE, Joshua David | Secrétaire | Bridgewater Place Birchwood Park WA3 6XF Warrington 305 United Kingdom | 323690970001 | |||||||
| CARTER, Roy Barrie | Administrateur | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 278245920001 | |||||
| JONES, Loren Michael | Administrateur | Bridgewater Place Birchwood Park WA3 6XF Warrington 305 United Kingdom | England | British | 278231220001 | |||||
| LYONS, Ellen | Administrateur | Bridgewater Place Birchwood Park WA3 6XF Warrington 305 United Kingdom | England | British | 205239320001 | |||||
| CHAUDHARY, Tejender Singh, Mr | Secrétaire | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 271554490001 | |||||||
| DON CAROLIS, Frazer Anthony | Secrétaire | 76 Riverside CW5 5HT Nantwich Cheshire | British | 22053220002 | ||||||
| FELLOWES, Colin | Secrétaire | 9 Thistlewood Drive Summerfields SK9 2RF Wilmslow Cheshire | British | 800670001 | ||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Secrétaire | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||
| HOLMAN, Rhona Mary | Secrétaire | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 305629330001 | |||||||
| JONES, Iain Angus | Secrétaire | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | 258145420001 | |||||||
| ROBERTS, Geoffrey | Secrétaire | Cottons Lane SE1 2QG London Cottons Centre United Kingdom | 312725500001 | |||||||
| THOMAS, Anthony Mark | Secrétaire | Booths Park, Chelford Road Knutsford WA16 8QZ Cheshire | 244370360001 | |||||||
| WARBURTON, Jennifer Ann | Secrétaire | Booths Park, Chelford Road Knutsford WA16 8QZ Cheshire | 211400570001 | |||||||
| RM REGISTRARS LIMITED | Secrétaire désigné | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900000760001 | |||||||
| ASHMAN, Fraser Lionel | Administrateur | 5 Garner Close Bowdon WA14 2JH Altrincham Cheshire | British | 73535420001 | ||||||
| CLARKSON, Iain Geoffrey | Administrateur | Booths Park, Chelford Road Knutsford WA16 8QZ Cheshire | United Kingdom | British | 155117130004 | |||||
| DAVIN, Julie | Administrateur | Booths Park, Chelford Road Knutsford WA16 8QZ Cheshire | United Kingdom | British | 170341200001 | |||||
| DURSTON, John Graham | Administrateur | 28 Hadrian Way Sandiway CW8 2JR Northwich Cheshire | England | British | 37359940001 | |||||
| EDWARDS, Sion Erwyd | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Wales | British | 45143840004 | |||||
| HIGTON, Peter Desmond | Administrateur | 61 Lyons Lane Appleton WA4 5JH Warrington Cheshire | England | British | 88673160001 | |||||
| INNS, Terry Peter Frank | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | England | British | 267610100001 | |||||
| ISLES, Rachael | Administrateur | Booths Park, Chelford Road Knutsford WA16 8QZ Cheshire | England | British | 186423040001 | |||||
| JONES, Thomas Leslie | Administrateur | Booths Park, Chelford Road Knutsford WA16 8QZ Cheshire | England | British | 186423300001 | |||||
| KERSHAW, Paul Richard | Administrateur | Meadowbank Willington Road, Willington CW6 0ND Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 59065240002 | |||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Administrateur | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | England | British | 42734310002 | |||||
| MARLOR, John Stanley | Administrateur | 8 Beechwood Avenue Hartford CW8 3AR Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 50328280001 | |||||
| SADLER, Steve | Administrateur | 25 Egerton Drive WA15 8EF Hale Cheshire | England | British | 206787920001 | |||||
| SMITH, Kevin | Administrateur | Tanner House Barn Higher Ramsgreave Road BB1 9DJ Mellor Lancashire | United Kingdom | British | 122477430001 | |||||
| WHITE, Andrew John | Administrateur | Bridgewater Place Birchwood Park WA3 6XF Warrington 305 United Kingdom | England | British | 186502480001 | |||||
| WOOD, Paul David | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | England | British | 220038000001 | |||||
| RM NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900009140001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMENTUM CLEAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Clean Energy Limited | 06 avr. 2016 | Bridgewater Place Birchwood Park WA3 6XG Warrington 305 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0