BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03266412
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED ?

    • Clubs avec licence (56301) / Hébergement et restauration

    Où se situe BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Haberfield Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAMBOS TRAFFORD LIMITED05 août 199805 août 1998
    HOTEL LODGE SALE LIMITED21 oct. 199621 oct. 1996

    Quels sont les derniers comptes de BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    10 pagesAA

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    10 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2016

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 oct. 2015

    État du capital au 23 oct. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2015

    10 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2014

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 oct. 2014

    État du capital au 27 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Divers

    Sec 519
    2 pagesMISC

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 oct. 2013

    État du capital au 21 oct. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    15 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan James Walker le 31 oct. 2011

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Albert House 17 Bloom Street Manchester M1 3HZ* le 22 juin 2011

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RIMMER, David Norman
    Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Ridgefield 23
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Ridgefield 23
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritish71617270002
    WALKER, Jonathan James
    Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Haberfield
    England
    Administrateur
    Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Haberfield
    England
    EnglandBritish39444010001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Secrétaire
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Secrétaire
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    British110216340001
    PEARSON, Andrew Guy
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    Secrétaire
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    British134403640001
    RICHMOND, Chantal Zenobia Renee
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    British17429610002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    ANDERSON, John Frederick
    69 Culcheth Hall Drive
    Culcheth
    WA3 4PX Warrington
    Administrateur
    69 Culcheth Hall Drive
    Culcheth
    WA3 4PX Warrington
    United KingdomBritish4569620002
    CUNNINGHAM, William Andrew
    4 Goodwood Rise
    CW10 9FJ Middlewich
    Cheshire
    Administrateur
    4 Goodwood Rise
    CW10 9FJ Middlewich
    Cheshire
    EnglandBritish113656620001
    DOBSON, Stephen
    24 Parklands Drive
    Weston
    CW2 5FH Crewe
    Administrateur
    24 Parklands Drive
    Weston
    CW2 5FH Crewe
    United KingdomBritish127852340001
    KOSSOWSKI, Mark Sylvester
    St Jude
    Stoney Lane
    SK9 6LG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    St Jude
    Stoney Lane
    SK9 6LG Wilmslow
    Cheshire
    British110423140001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish110216340001
    PANAYI, Panico
    Kpmg
    Elma House 10 Mnasladou Streeet
    FOREIGN 1065 Nicosia
    Cyprus
    Administrateur
    Kpmg
    Elma House 10 Mnasladou Streeet
    FOREIGN 1065 Nicosia
    Cyprus
    CyprusBritish9075400007
    PEARSON, Andrew Guy
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    Administrateur
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    EnglandBritish134403640001
    RICHMOND, Chantal Zenobia Renee
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    3 Brookside
    Cuddington
    CW8 2QA Northwich
    Cheshire
    British17429610002
    TAYLOR, Graham Jack
    36 Ullswater Drive
    Killingworth
    NE12 8GX Newcastle
    Administrateur
    36 Ullswater Drive
    Killingworth
    NE12 8GX Newcastle
    British110423300001
    WALSH, Neil
    The Paddock
    Beardwood
    BB2 7QY Blackburn
    2
    Lancashire
    Administrateur
    The Paddock
    Beardwood
    BB2 7QY Blackburn
    2
    Lancashire
    United KingdomBritish134469650001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Buckingham Bingo Limited
    Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Haberfield
    Lancashire
    England
    06 avr. 2016
    Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Haberfield
    Lancashire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement0991810
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BUCKINGHAM TRAFFORD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of a contract by way of security
    Créé le 09 avr. 2010
    Livré le 22 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The security assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    249 stanley road bootle t/n MS235764 bingo club poplar bank huyton knowsley merseyside t/n MS365314 601 chester road old trafford t/n GM817722 for furter details of the properties charged please refer to form 395 the real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    601 chester road old trafford t/n LA202173.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    601 chester road old trafford t/n GM483595.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    601 chester road old trafford t/n GM196332.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    601 chester road old trafford t/n GM817722.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 12 nov. 1999
    Livré le 16 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each associated company
    Brèves mentions
    The f/h and l/h property k/a buckingham bingo club talbot road/chester road old trafford greater manchester and the proceeds of sale of the property and all buildings and fixtures. The insurance policy of the property, the equipment and all claims and proceeds in respect of such insurance.
    Personnes ayant droit
    • Carlsberg Tetley Brewing Limited
    Transactions
    • 16 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 avr. 1999
    Livré le 21 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as premises on the south side of chester road the north side of talbot road old trafford greater manchester title numbers LA194926, LA142473(part), GM763191(part). And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 avr. 1999
    Livré le 21 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as premises on the south side of chester road and on the north side of talbot road old trafford greater manchester title number GM196332, GM483595, LA202173. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 avr. 1999
    Livré le 19 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0