SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED

SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03271135
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Level 23
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 17 juil. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2013

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2014

    État du capital au 03 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Po Box 67238 10-18 Union Street London SE1P 4DL

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2010

    16 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pellipar House 1St Floor, 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Tmf Corporate Administration Services Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * First Floor 6 Broadgate London EC2M 2QS* le 17 déc. 2010

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2009

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Clifford Chance Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination d'un secrétaire

    2 pagesAP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRANDON, Lee Christopher
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 23
    England
    Administrateur
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    Level 23
    England
    United KingdomBritishDirector152214440001
    GUY, Bernard A
    19007 Sw Eastside Road
    Lake Oswego
    97034 Oregon
    Usa
    Secrétaire
    19007 Sw Eastside Road
    Lake Oswego
    97034 Oregon
    Usa
    Us Citizen 50788580001
    OLIVER, Wendy Beth
    2035 Se
    76th Avenue
    97215 Portland
    Oregon
    Secrétaire
    2035 Se
    76th Avenue
    97215 Portland
    Oregon
    American59498560001
    PALMER, Gary
    1035 Tyndall Court
    Lake Oswego
    97035 Oregon
    Usa
    Secrétaire
    1035 Tyndall Court
    Lake Oswego
    97035 Oregon
    Usa
    Us CitizenChief Financial Officer Vp50788880001
    AQUIS SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    73062690001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    S & A DIRCTORS LIMITED
    C/O Sidley & Austin
    Royal Exchange Steps
    EC3V 3LE London
    Secrétaire
    C/O Sidley & Austin
    Royal Exchange Steps
    EC3V 3LE London
    53340570001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Secrétaire
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    AITKEN, Stuart Gilbert
    6 Haven Court
    Berrylands
    KT5 8JF Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    6 Haven Court
    Berrylands
    KT5 8JF Surbiton
    Surrey
    BritishDirector82148470001
    ATTIA, Amany
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    Administrateur
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    United KingdomFrench - AmericanManaging Director94699620002
    BILSBOROUGH, William C
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Us CitizenBanker107220450001
    CHAMBERS, Paul Stuart
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    Administrateur
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    United KingdomBritishAccountant172496620001
    CHERRY, William Edward
    8 Gordon Place
    W8 4JD London
    Administrateur
    8 Gordon Place
    W8 4JD London
    AmericanDirector49950020002
    DAVIES, Angela Sarah Mary
    4 Parklands Grove
    TW7 5DD Isleworth
    Middlesex
    Administrateur
    4 Parklands Grove
    TW7 5DD Isleworth
    Middlesex
    BritishDirector64198090002
    FRASER, George Mclennan
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    Administrateur
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    AustralianExecutive Director94699810001
    GIBB, Dominic Iain
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    Administrateur
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    BritishChartered Accountant62250460004
    GUY, Bernard A
    19007 Sw Eastside Road
    Lake Oswego
    97034 Oregon
    Usa
    Administrateur
    19007 Sw Eastside Road
    Lake Oswego
    97034 Oregon
    Usa
    Us Citizen 50788580001
    HINSHELWOOD, Wallace Simon Duthie
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director91642420002
    HOWARD, Ronald W
    563
    Ashdown Circle
    97068 W Linn
    Oregon
    Usa
    Administrateur
    563
    Ashdown Circle
    97068 W Linn
    Oregon
    Usa
    Us CitizenPresident Ceo Officer50789050001
    KEEBLE, Anthony John
    29 Stocklands Way
    Prestwood
    HP16 0SJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    29 Stocklands Way
    Prestwood
    HP16 0SJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director103011320001
    LEASK, Melanie Joan
    Oakdale
    19 Crescent Road
    TW17 8BL Shepperton
    Middlesex
    Administrateur
    Oakdale
    19 Crescent Road
    TW17 8BL Shepperton
    Middlesex
    BritishMortgage Servicing Director103063210001
    MCHUGH, Gerald Martin
    Oakenhall
    Singleton Road, Great Chart
    TN23 3BA Ashford
    Kent
    Administrateur
    Oakenhall
    Singleton Road, Great Chart
    TN23 3BA Ashford
    Kent
    United KingdomBritishInvestment Banking115957570001
    MEHR, Amir
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    United KingdomAmericanBanker130034860001
    PALMER, Gary
    1035 Tyndall Court
    Lake Oswego
    97035 Oregon
    Usa
    Administrateur
    1035 Tyndall Court
    Lake Oswego
    97035 Oregon
    Usa
    Us CitizenChief Financial Officer Vp50788880001
    PRUST, John Matthew
    63 High View
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    63 High View
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    BritishDirector64198070001
    RUPP, Christopher Gordon
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishBanking72545640001
    STAID, Stephen
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomAmericanBanker125380160001
    TOWNSEND, Andrew Christopher
    2 Stopps Orchard
    Monks Risborough
    HP27 2JB Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Stopps Orchard
    Monks Risborough
    HP27 2JB Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishDirector8596390002
    WEIR, Louise Jane
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    Administrateur
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    EnglandBritishBanker130033570001

    SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A warehouse deed of charge
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 05 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit present and future, in the security assets including, in relation to the english mortgage loans and northern irish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Storm Funding Limited
    Transactions
    • 05 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge
    Créé le 30 juin 1999
    Livré le 08 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations (whether actual or contingent present or future) of southern pacific funding 2 limited a wholly owned subsidiary of the company to the chargee under the warehouse facility (as defined)
    Brèves mentions
    All right title and interest in the ordinary deferred consideration and the special deferred consideration all rights to the repayment of monies stamding to the credit of the decured loan account by way of floating charge the whole of it's undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of charge
    Créé le 15 avr. 1999
    Livré le 26 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of southern pacific mortgage limited owed to the chargee under the overdraft facility letter
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in and to the ordinary deferred consideration and the special deferred consideration and all sums payable or to become payable in respect of the ordinary deferred consideration and the special deferred consideration pursuant to the mortgage sale agreement (for full details see form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge (as defined)
    Créé le 10 sept. 1998
    Livré le 29 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    All rights,title,benefit and interest in the security assets (as defined) and all principal monies payable; see form 395. undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 07 juil. 1997
    Livré le 18 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee including but without limitation all monies and facilities from time to time due owing or incurred by the company under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including book debts uncalled capital accounts, causes of action, the building policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley & Co. International Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SOUTHERN PACIFIC FUNDING I LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 juil. 2015Commencement of winding up
    29 mai 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0