CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCUMBRIAN HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03275686
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ?

    • Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques (10200) / Industries manufacturières

    Où se situe CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CUMBRIAN SEAFOODS LIMITED17 févr. 199717 févr. 1997
    HOODCO 531 LIMITED08 nov. 199608 nov. 1996

    Quels sont les derniers comptes de CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 mars 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Progress report ends 13/01/2016
    13 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Progress Report
    15 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidators progress report
    9 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:progress report
    12 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 sept. 2012

    16 pages2.24B

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    19 pages2.33B

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 juin 2012

    23 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    1 pages2.17B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    40 pages2.17B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    24 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    17 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * Foxcover 7 Admiralty Way Foxcover Industrial Estate Seaham County Durham SR7 7DN* le 05 janv. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2011

    État du capital au 11 nov. 2011

    • Capital: GBP 846,233
    SH01

    Cessation de la nomination de Michael Vassallo en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    7 pagesMG01

    Cessation de la nomination de Howard Sims en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VASSALLO, Peter
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    Secrétaire
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    BritishCompany Director49018830002
    GILTHORPE, David Alexander
    Lady Park Farm Cottage Lady Park
    NE11 0HD Gateshead
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Lady Park Farm Cottage Lady Park
    NE11 0HD Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishChartered Accountant42515160001
    VASSALLO, Peter
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    Administrateur
    Lauder Grange
    Prospect Hill
    NE45 5RS Corbridge
    Northumberland
    EnglandBritishCompany Director49018830002
    ALLAN, Peter Riddle
    5 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    5 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishSolicitor35573440001
    ROGAN, Eileen Theresa
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    Secrétaire désigné
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British900013580001
    FLYNN, Austin
    201 Sandyford Road
    NE2 1NP Newcastle Upon Tyne
    Administrateur désigné
    201 Sandyford Road
    NE2 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900009310001
    FORSYTH, Martin Peter
    Broomlands
    High Lorton
    CA13 9UL Cockermouth
    Cumbria
    Administrateur
    Broomlands
    High Lorton
    CA13 9UL Cockermouth
    Cumbria
    BritishCompany Director56015200003
    PORTERGILL, Richard George
    Abbey View
    Henley Road
    SL7 2DQ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Abbey View
    Henley Road
    SL7 2DQ Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director2563880005
    RHODES, David Mitchell
    Greenacres
    Ullock
    CA14 4TP Cockermouth
    Cumbria
    Administrateur
    Greenacres
    Ullock
    CA14 4TP Cockermouth
    Cumbria
    BritishCompany Director75199880001
    ROGAN, Eileen Theresa
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    Administrateur désigné
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British900013580001
    SIMS, Howard
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    Administrateur
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    EnglandBritishCompany Director156051970001
    VASSALLO, Michael
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    Administrateur
    Admiralty Way
    Foxcover Industrial Estate
    SR7 7DN Seaham
    Foxcover 7
    County Durham
    EnglandBritishChartered Accountant156050660001

    CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed
    Créé le 19 oct. 2011
    Livré le 24 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the property specified in the schedule of the supplemental deed, being more particularly: 1 ordinary share of £1.00 in cumbrian seafoods limited, 1 ordinary share of £1.00 in cumbrian shellco limited and 100 ordinary shares of £1.00 each in border laird limited see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge over shares
    Créé le 19 août 2009
    Livré le 26 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charged securities, means the 100,000 new ordinary shares of grants smokehouse limited all related rights, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Aircraft mortgage
    Créé le 30 nov. 1999
    Livré le 11 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £581,000 together with all sums due or to become due from the company and cumbrian seafoods inc to the charge under the terms of the transaction documents by way of principal or interest
    Brèves mentions
    Md helicopters 600 notar helicopter s/n RN048 reg mark n-600PV the insurance and the requisition compensation.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 24 août 1999
    Livré le 03 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 03 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 25 sept. 1997
    Livré le 08 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Equipment such ASB9 fiigoscandia frying line, deglazer, predust s/n 8010-14-1143, batter applicator s/n 10-14-1143, breader s/n 010-14-1143, conveyor s/n DF301G25PD, fryer (model tff-2415) s/m 273, abc satter machine s/n 075-01-1069 etc for further chattels please see schedule attatched to form 395.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account assignment
    Créé le 25 sept. 1997
    Livré le 08 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of lease agreements
    Brèves mentions
    All moneys from time to time credited and for the time being standing to the credit of account 30608963 with barclays bank PLC together with all debts represented thereby the cash collateral account and such other assets.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 03 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units BT200/2 3 and 5 solway industrial estate maryport allerdale cumbria.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 21 août 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 04 nov. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 juil. 1997
    Livré le 04 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CUMBRIAN HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 sept. 2012Administration ended
    05 déc. 2011Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert James Hebenton
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Toby Scott Underwood
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    2
    DateType
    14 sept. 2012Commencement of winding up
    11 juin 2016Dissolved on
    13 janv. 2016Conclusion of winding up
    07 sept. 2012Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert James Hebenton
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Toby Scott Underwood
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0