CONCATENO CARDIFF LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONCATENO CARDIFF LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03276164
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONCATENO CARDIFF LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CONCATENO CARDIFF LIMITED ?

    Adresse du siège social
    92 Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    Oxfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CONCATENO CARDIFF LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRICHO-TECH LIMITED24 janv. 199724 janv. 1997
    MB68 LIMITED11 nov. 199611 nov. 1996

    Quels sont les derniers comptes de CONCATENO CARDIFF LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CONCATENO CARDIFF LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CONCATENO CARDIFF LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Robert Macnaughton en tant que directeur le 17 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Neil James en tant qu'administrateur le 31 janv. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Anthony John Wall en tant qu'administrateur le 31 janv. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher James Tarpey en tant que directeur le 31 janv. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Geoffrey John Couling en tant que secrétaire le 31 janv. 2014

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Ross Macken en tant que directeur le 31 janv. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 déc. 2013

    État du capital au 13 déc. 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 92 Milton Park Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4RY England

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 92 Milton Park Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4RY United Kingdom le 12 déc. 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Robert Macnaughton en tant qu'administrateur le 06 nov. 2013

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian William Fieldhouse en tant que directeur le 06 nov. 2013

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Ian William Fieldhouse en tant qu'administrateur le 23 mai 2013

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Katharine Hannah Wright en tant que directeur le 23 mai 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martyn Robert Pither en tant que directeur le 23 mai 2013

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Graham Neil Sievers en tant que directeur le 13 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    19 pagesAA

    Nomination de Mr Christopher James Tarpey en tant qu'administrateur le 14 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Nomination de Ross Macken en tant qu'administrateur le 02 avr. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Geoffrey Welch en tant que directeur le 02 avr. 2012

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CONCATENO CARDIFF LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Neil Edward
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director252184730001
    WALL, Anthony John
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    EnglandBritishBusiness Executive61591420004
    COULING, Geoffrey John
    University Way
    Cranfield Technology Park
    MK43 0AZ Cranfield
    Derwent House
    Bedfordshire
    Secrétaire
    University Way
    Cranfield Technology Park
    MK43 0AZ Cranfield
    Derwent House
    Bedfordshire
    152358960001
    ELTON, Neil Anthony
    130 Wapping High Street
    E1 2NH London
    23 Gun Wharf
    Secrétaire
    130 Wapping High Street
    E1 2NH London
    23 Gun Wharf
    British146755010001
    LASS, Rosemary Anne
    Fox Hill
    Henley Road
    CV35 8LJ Claverdon
    Warwickshire
    Secrétaire
    Fox Hill
    Henley Road
    CV35 8LJ Claverdon
    Warwickshire
    BritishDirector34137170001
    NIXON, Rowena
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    Secrétaire
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    BritishCompany Secretary130534400001
    TSANACLIS, Lolita Margareta, Dr
    33 Barons Court Road
    Penylan
    CF23 9DG Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire
    33 Barons Court Road
    Penylan
    CF23 9DG Cardiff
    South Glamorgan
    BritishDirector64787530001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secrétaire
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEGLEY, Fiona
    10 Barley Mead
    SL6 3TE Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    10 Barley Mead
    SL6 3TE Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomIrishCompany Director69067860002
    ELTON, Neil Anthony
    23 Gun Wharf
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    Administrateur
    23 Gun Wharf
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    EnglandBritishFinance Director74129080002
    FIELDHOUSE, Ian William
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant104466570001
    LASS, Rosemary Anne
    Fox Hill
    Henley Road
    CV35 8LJ Claverdon
    Warwickshire
    Administrateur
    Fox Hill
    Henley Road
    CV35 8LJ Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector34137170001
    MACKEN, Ross Gwynfor
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritishOperations Director168704390001
    MACNAUGHTON, Robert Ian
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant182684250001
    PITHER, Martyn Robert
    University Way
    Cranfield Technology Park
    MK43 0AZ Cranfield
    Derwent House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    University Way
    Cranfield Technology Park
    MK43 0AZ Cranfield
    Derwent House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant152345470001
    SIEVERS, Graham Neil
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDevelopment Director78899310001
    TARPEY, Christopher James
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    England
    United StatesAmericanDirector172086510001
    TOZZI, Keith
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    Administrateur
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    United KingdomBritishCompany Director151819750001
    TSANACLIS, Lolita Margareta, Dr
    33 Barons Court Road
    Penylan
    CF23 9DG Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    33 Barons Court Road
    Penylan
    CF23 9DG Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishDirector64787530001
    WANLESS, Barry
    Dovedale Farm Manselfield Road
    Murton
    SA3 3AP Swansea
    Wales
    Administrateur
    Dovedale Farm Manselfield Road
    Murton
    SA3 3AP Swansea
    Wales
    WalesBritishDirector55898930001
    WELCH, Peter Geoffrey
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director30604130001
    WICKS, Elizabeth Francis Helen Lucy
    35 Ninian Road
    CF23 5EG Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    35 Ninian Road
    CF23 5EG Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritishDirector105009980001
    WICKS, John Francis Charles
    35
    Ninian Road
    CF2 5EG Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    35
    Ninian Road
    CF2 5EG Cardiff
    South Glamorgan
    BritishDirector34137150002
    WOODS, Rachel Jane
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager135772130001
    WRIGHT, Katharine Hannah
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Milton Park
    Milton
    OX14 4RY Abingdon
    92
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director152396780001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CONCATENO CARDIFF LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 05 févr. 2007
    Livré le 07 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 07 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 nov. 2005
    Livré le 10 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 03 nov. 2004
    Livré le 05 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1A pentwyn business park, wharfdale road, pentwyn, cardiff. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 août 2004
    Livré le 21 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0