BARLEY SHOWHOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBARLEY SHOWHOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03278299
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BARLEY SHOWHOMES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BARLEY SHOWHOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    20 Berkeley Square
    London
    W1J 6LH
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BARLEY SHOWHOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRUSHELFCO (NO.2206) LIMITED14 nov. 199614 nov. 1996

    Quels sont les derniers comptes de BARLEY SHOWHOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BARLEY SHOWHOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 nov. 2012

    État du capital au 16 nov. 2012

    • Capital: GBP 11
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Nicholas Salisbury en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Fiona Freeman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Bernard Sunley le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Evans le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Rory William Michael Gleeson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sunley Securities Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BARLEY SHOWHOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SUNLEY SECURITIES LIMITED
    Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    20
    United Kingdom
    Secrétaire
    Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    20
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2262230
    77371660001
    EVANS, Richard
    20 Berkeley Square
    London
    W1J 6LH
    Administrateur
    20 Berkeley Square
    London
    W1J 6LH
    United KingdomBritish99065600001
    GLEESON, Rory William Michael
    20 Berkeley Square
    W1J 6LH London
    Administrateur
    20 Berkeley Square
    W1J 6LH London
    EnglandIrish104706720007
    SUNLEY, James Bernard
    Berkeley Square
    W1J 6LH London
    20
    Administrateur
    Berkeley Square
    W1J 6LH London
    20
    EnglandBritish43436300006
    DAY, Ann Elizabeth
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    Secrétaire
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    British59224910003
    MILLGATE, Sean
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Secrétaire
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    British26295060002
    PROUD, Christopher Wilfred Fredrick
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    British41375220002
    ROWLEY, Paul
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    British89958260001
    STRACHAN, Sylvia Rose
    17 Mciver Close
    Felbridge
    RH19 2PN East Grinstead
    West Sussex
    Secrétaire
    17 Mciver Close
    Felbridge
    RH19 2PN East Grinstead
    West Sussex
    British57230090001
    SUNLEY SECURITIES LIMITED
    20 Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    Secrétaire
    20 Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    77371660001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secrétaire désigné
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    DAY, Ann Elizabeth
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    Administrateur
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    British59224910003
    FREEMAN, Fiona Lynne
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United KingdomBritish137805060001
    FREEMAN, Fiona Lynne
    21 Fir Tree Close
    KT17 3LD Epsom
    Surrey
    Administrateur
    21 Fir Tree Close
    KT17 3LD Epsom
    Surrey
    British73653530001
    MILLGATE, Sean
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Administrateur
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    British26295060002
    PARR, Richard Charles Neale
    Forest View
    19 Estcots Drive
    RH19 3DA East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Forest View
    19 Estcots Drive
    RH19 3DA East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish87872830001
    PAYNE, Richard William Norris
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish77845170003
    PROUD, Christopher Wilfred Fredrick
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    British41375220002
    REARDON, Pamela Mae
    37 Thames Close
    KT16 8NQ Chertsey
    Surrey
    Administrateur
    37 Thames Close
    KT16 8NQ Chertsey
    Surrey
    British70841810001
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Administrateur désigné
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British900010990001
    ROWLEY, Paul
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    British89958260001
    SALISBURY, Nicholas William
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish4380320005
    SPARROW, Derek Tuart
    52 Brittany Road
    BN3 4PB Hove
    East Sussex
    Administrateur
    52 Brittany Road
    BN3 4PB Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish23780460003
    TICE, Richard James Sunley
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish151240670006
    TINDALL, Terence William
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish4380330001
    TUCKER, Gary William
    18 The Castle
    Holbrook
    RH12 5PX Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    18 The Castle
    Holbrook
    RH12 5PX Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish82937600001
    WIBLING, Andrew Charles
    Kilchurn
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Kilchurn
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    British74387530001
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur désigné
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British900014530001

    BARLEY SHOWHOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 août 2003
    Livré le 11 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Plot 79 lacuna west malling kent part t/n K818481, plot 5 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002 and plot 110 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Properties Limited
    Transactions
    • 11 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 août 2003
    Livré le 11 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Plot 79 lacuna west malling kent part t/n K818481, plot 5 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002 and plot 110 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 oct. 2002
    Livré le 25 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including (I) plot 1 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (ii) plot 2 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (iii) plot 3 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Properties Limited
    Transactions
    • 25 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 oct. 2002
    Livré le 25 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including (I) plot 1 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (ii) plot 2 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (iii) plot 3 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 2002
    Livré le 25 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 63 lacuna, discovery drive, kings hill, west malling, kent part of t/n K818481. Plot 17 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Plot 18 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Properties Limited
    Transactions
    • 25 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 2002
    Livré le 25 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 63 lacuna, discovery drive, kings hill, west malling, kent part of t/n K818481. Plot 17 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Plot 18 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2002
    Livré le 07 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Plot 63 lacuna discovery drive kings hill west malling kent part t/n K818481, plot 17 borrerfields henfield part t/n WSX257853 and plot 18 borrerfields henfield part t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Properties Limited
    Transactions
    • 07 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2002
    Livré le 07 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Plot 63 lacuna discovery drive kings hill west malling kent part t/n K818481, plot 17 borrerfields henfield part t/n WSX257853 and plot 18 borrerfields henfield part t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2001
    Livré le 08 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2001
    Livré le 08 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Properties Limited
    Transactions
    • 08 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 janv. 1999
    Livré le 03 févr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 janv. 1999
    Livré le 03 févr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Properties Limited
    Transactions
    • 03 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1996
    Livré le 07 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sunley Properties Limited
    Transactions
    • 07 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1996
    Livré le 07 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0