SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED

SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03278371
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Severn Trent Centre
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRUSHELFCO (NO.2204) LIMITED14 nov. 199614 nov. 1996

    Quels sont les derniers comptes de SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juin 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 juin 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juin 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    25 pagesMA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2024

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Hannah Woodall-Pagan en tant qu'administrateur le 15 mars 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Eadie en tant que directeur le 15 mars 2024

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    3 pagesAA

    Nomination de Mrs Gemma Eagle en tant que secrétaire le 19 juin 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Aline Anne Campbell en tant que secrétaire le 19 juin 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Notification de Severn Trent Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 févr. 2019

    2 pagesPSC02

    Cessation de Severn Trent Corporate Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 févr. 2019

    1 pagesPSC07

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Richard Eadie en tant qu'administrateur le 29 mars 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Qui sont les dirigeants de SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EAGLE, Gemma
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    Secrétaire
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    259676850001
    MCPHEELY, Robert Craig
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    Administrateur
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    EnglandBritishAccountant104273610001
    WOODALL-PAGAN, Hannah
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    Administrateur
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    EnglandBritishCompany Director306891510001
    ARMITAGE, Matthew
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Secrétaire
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    157948620001
    BRIERLEY, Richard Paul
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Secrétaire
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    153773700001
    CAMPBELL, Aline Anne
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    Secrétaire
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    191783390001
    DAVIES, Peter Peers
    Birch House 20 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JA Birmingham
    Secrétaire
    Birch House 20 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JA Birmingham
    British58764390002
    HEATHER, John Langdale
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    Secrétaire
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    British33307810001
    MATTIN, David William
    Moonrakers
    Dark Lane Bliss Gate Rock
    DY14 9YN Kidderminster
    Worcestershire
    Secrétaire
    Moonrakers
    Dark Lane Bliss Gate Rock
    DY14 9YN Kidderminster
    Worcestershire
    British2509430001
    WILKINSON, Caroline Lesley
    55 Inglewood Grove
    B74 3LN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    55 Inglewood Grove
    B74 3LN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British68331390001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secrétaire désigné
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    ALLCOCK, Suzanne Tracy
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    Administrateur
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    EnglandBritishCompany Director277736230001
    BISHOP, Michael
    Stowe House
    39 Abbey Lane
    CV47 1HR Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    Stowe House
    39 Abbey Lane
    CV47 1HR Southam
    Warwickshire
    BritishCivil Engineer104432000001
    BOYD, Alan Kerr
    No 1 Over Ross Farm
    Ledbury Road
    HR9 7BN Ross On Wye
    Herefordshire
    Administrateur
    No 1 Over Ross Farm
    Ledbury Road
    HR9 7BN Ross On Wye
    Herefordshire
    BritishReclamation Controller31058720001
    BRANDON, Mark Richard
    1a Diglis Lane
    WR5 3DQ Worcester
    Administrateur
    1a Diglis Lane
    WR5 3DQ Worcester
    BritishCompany Director117669340001
    BRIDGE, Robert Anthony
    57 Cobden Street
    Wollaston
    DY8 3RT Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    57 Cobden Street
    Wollaston
    DY8 3RT Stourbridge
    West Midlands
    BritishTechnical Operator56116340001
    CASSONI, Maria Luisa
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    Administrateur
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    EnglandBritishDirector Of Companies74583340001
    COSTIN, Ronald Alan Stuart
    Woodview Redland End
    HP27 0RW Speen
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodview Redland End
    HP27 0RW Speen
    Buckinghamshire
    BritishDirector23675910001
    DAGLEY, Graham
    No 1 Cottage Lodge Lane
    Bradgate Road Cropston
    LE7 7GB Leicester
    Administrateur
    No 1 Cottage Lodge Lane
    Bradgate Road Cropston
    LE7 7GB Leicester
    BritishAssistant Operation Controller52259880001
    DAVIES, Peter Peers
    Birch House 20 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JA Birmingham
    Administrateur
    Birch House 20 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JA Birmingham
    BritishCompany Secretary Solicitor58764390002
    DONNELLY, David Alexander
    Silverdale House
    Chelmarsh
    WV16 6BA Bridgnorth
    Salop
    Administrateur
    Silverdale House
    Chelmarsh
    WV16 6BA Bridgnorth
    Salop
    BritishFinance Manager56089490001
    DOVEY, Mark James, Mr.
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Tax Manager166254070001
    DUGGAN, James
    86 Prince Thorpe Road
    Weoley Castle
    B29 5QA Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    86 Prince Thorpe Road
    Weoley Castle
    B29 5QA Birmingham
    West Midlands
    IrishStores Operative31055100001
    EADIE, Richard
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector208711590001
    FENN, Jonathan Mark
    Smartswell Willow Wents
    Mereworth
    ME18 5NF Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Smartswell Willow Wents
    Mereworth
    ME18 5NF Maidstone
    Kent
    BritishSolicitor9491480002
    FISHER, Gerald
    Beechlea 10 Ratcliffe Lane
    Sheepy Magna
    CV9 3QY Atherstone
    Warwickshire
    Administrateur
    Beechlea 10 Ratcliffe Lane
    Sheepy Magna
    CV9 3QY Atherstone
    Warwickshire
    BritishGp Per Director13553810001
    FORD, Christopher John
    20 Thompson Close
    East Leak
    LE12 6HP Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    20 Thompson Close
    East Leak
    LE12 6HP Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director113424060001
    HEER, Harpal Singh
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    Administrateur
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    BritishCivil Engineer79110030002
    HENDERSON, Grahame
    4 Rectory Gardens
    Todwick
    S26 1JU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    4 Rectory Gardens
    Todwick
    S26 1JU Sheffield
    South Yorkshire
    BritishAccountant65552060001
    HOLBROOK, Gary Richard
    16 Melville Close
    UB10 8TZ Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    16 Melville Close
    UB10 8TZ Uxbridge
    Middlesex
    BritishInsurance Broker56089210001
    HORNER, Brian Michael
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    Administrateur
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    BritishFinancial Director35521630004
    IRELAND, Richard
    10 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    10 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector272320001
    JONES, Keith
    27 Chestnut Grove
    Great Stukeley
    PE28 4AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    27 Chestnut Grove
    Great Stukeley
    PE28 4AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishActuary78724560001
    LEWIS, Roger Kingston
    1 Belsize Lane
    NW3 5AA London
    Administrateur
    1 Belsize Lane
    NW3 5AA London
    United KingdomBritishSolicitor14516060001
    LISTER, Gwyneth Margaret
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    Administrateur
    2297 Coventry Road
    Birmingham
    B26 3PU
    BritishAccountant127052470001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SEVERN TRENT PIF TRUSTEES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Severn Trent Holdings Limited
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    22 févr. 2019
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House (England And Wales)
    Numéro d'enregistrement05656363
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Severn Trent Corporate Holdings Limited
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    06 avr. 2017
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House (England And Wales)
    Numéro d'enregistrement4395566
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0