PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPENN HOUSE PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03287110
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED ?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Où se situe PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CIVILEMPLOY LIMITED03 déc. 199603 déc. 1996

    Quels sont les derniers comptes de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 févr. 2010

    État du capital au 10 févr. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Trafalgar Officers Limited le 03 déc. 2009

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Reit(Corporate Services) Limited le 03 déc. 2009

    1 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    14 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    Qui sont les dirigeants de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed
    Créé le 30 oct. 1997
    Livré le 11 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 30 october 1997
    Brèves mentions
    The properties listed below together with all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases, underleases, tenancies, agreements to lease, rights, covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. Land an buildings on the south west side of crown street manchester GM52341. L/h land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester LA328553.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 11 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 22 août 1997
    Livré le 23 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under or in connection with a sale and purchase agreement dated 23RD december 1996 and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on the south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836; l/h property k/a land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester t/no: LA328553 all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property including any items at the original property; any proceeds of any insurance of the original real property; and a fixed charge over the rental income of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Canada Life Assurance Company
    Transactions
    • 23 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge
    Créé le 23 déc. 1996
    Livré le 09 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and any holding or subsidiary company or any other group member to the chargee (as trustee for itself and the other lenders) on any account whatsoever or in any manner whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises on the west side of windsor bridge road bath north estate somerset AV81568 somerset hall somerset street bath AV33403 and AV33404 and AV184057 and all buildings and erections and by way of floating charge all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 09 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 déc. 1996
    Livré le 04 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a sale and purchase agreement between the company the chargee and estates & general PLC dated 23RD december 1996 on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 13/15 old steine and 1A/1B st. James' street brighton t/n: ESX21909; l/h property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836 and other properties referred to in schedule together with all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property, its goodwill and uncalled capital floating charge over the undertaking and property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Canada Life Assurance Company
    Transactions
    • 04 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0